Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2019 13 tarjetas
16/01/2019 Sec. I Reelecciones Ourense
Ourense-17329

Reelecciones — 16/01/2019

Reelecciones. Auditor: APUMAR AUDITORES SLP. Datos registrales. T 746 , F 160, S 8, H OR 146, I/A 32 ( 2.01.19).

02/10/2018 Sec. I Ampliación de capital Ourense
Ourense-396393

Ampliación de capital — 02/10/2018

Ampliación de capital. Suscrito: 3.000.000,00 Euros. Desembolsado: 3.000.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.600.000,00 Euros. Resultante Desembolsado: 3.600.000,00 Euros. Datos registrales. T 746 , F 159, S 8, H OR 14...

21/08/2018 Sec. I Nombramientos Ourense
Ourense-345125

Nombramientos — 21/08/2018

Nombramientos. Apo.Sol.: SANTOS IGLESIAS JESUS;DIEGUEZ OTERO ALBERTO LUIS. Datos registrales. T 746 , F 159, S 8, H OR 146, I/A 30 ( 1.08.18).

26/01/2016 Sec. I Nombramientos Ourense
Ourense-32594

Nombramientos — 26/01/2016

Nombramientos. Auditor: APUMAR AUDITORES SLP. Datos registrales. T 746 , F 159, S 8, H OR 146, I/A 29 (15.01.16).

23/06/2015 Sec. I Ceses/Dimisiones Ourense
Ourense-257631

Ceses/dimisiones — 23/06/2015

Ceses/Dimisiones. Consejero: RODRIGUEZ GARCIA FRANCISCO;GONZALEZ RODRIGUEZ FELISINDO;COBAS PENA ANGEL;RODRIGUEZ SEGADE JAVIER;SOTO DIAZ GERMAN. Presidente: RODRIGUEZ GARCIA FRANCISCO. Cons.Del.Sol: COBAS PENA ANGEL. Sec...

09/12/2013 Sec. I Reelecciones Ourense
Ourense-524848

Reelecciones — 09/12/2013

Reelecciones. Auditor: AUDITORES DE FINANZAS ASOCIADOS SL. Datos registrales. T 746 , F 158, S 8, H OR 146, I/A 27 (26.11.13).

04/02/2013 Sec. I Reelecciones Ourense
Ourense-54887

Reelecciones — 04/02/2013

Reelecciones. Auditor: AUDITORES DE FINANZAS ASOCIADOS SL. Datos registrales. T 746 , F 158, S 8, H OR 146, I/A 26 (23.01.13).

31/05/2012 Sec. I Ceses/Dimisiones Ourense
Ourense-231753

Ceses/dimisiones — 31/05/2012

Ceses/Dimisiones. Secretario: SOTO DIAZ GERMAN. Cons.Del.Sol: SOTO DIAZ GERMAN. Nombramientos. Secretario: COBAS PENA ANGEL. Cons.Del.Sol: RODRIGUEZ SEGADE JAVIER. Datos registrales. T 746 , F 158, S 8, H OR 146, I/A 25...

10/11/2011 Sec. I Ceses/Dimisiones Ourense
Ourense-446719

Ceses/dimisiones — 10/11/2011

Ceses/Dimisiones. Consejero: RODRIGUEZ GARCIA FRANCISCO. Presidente: RODRIGUEZ GARCIA FRANCISCO. Consejero: SOTO DIAZ GERMAN. Secretario: SOTO DIAZ GERMAN. Consejero: GONZALEZ RODRIGUEZ FELISINDO. Cons.Del.Sol: RODRIGUE...

30/11/2010 Sec. I Nombramientos Ourense
Ourense-443140

Nombramientos — 30/11/2010

Nombramientos. Apoderado: PEREZ BERNARDEZ MARIA DOLORES. Datos registrales. T 746 , F 157, S 8, H OR 146, I/A 23 (17.11.10).

12/02/2010 Sec. I Revocaciones Ourense
Ourense-61669

Revocaciones — 12/02/2010

Revocaciones. Auditor: NUÑEZ COELLO ALFONSO. Aud.Supl.: SERVIA SANTOS FRANCISCO. Nombramientos. Auditor: AUDITORES DE FINANZAS ASOCIADOS SL. Datos registrales. T 746 , F 156, S 8, H OR 146, I/A 22 (22.01.10).

24/12/2009 Sec. I Reelecciones Ourense
Ourense-536350

Reelecciones — 24/12/2009

Reelecciones. Consejero: RODRIGUEZ GARCIA FRANCISCO. Presidente: RODRIGUEZ GARCIA FRANCISCO. Consejero: SOTO DIAZ GERMAN. Secretario: SOTO DIAZ GERMAN. Consejero: GONZALEZ RODRIGUEZ FELISINDO. Cons.Del.Sol: RODRIGUEZ GA...

05/02/2009 Sec. I Reelecciones Ourense
Ourense-64999

Reelecciones — 05/02/2009

Reelecciones. Auditor: NUÑEZ COELLO ALFONSO. Aud.Supl.: SERVIA SANTOS FRANCISCO. Datos registrales. T 746 , F 156, S 8, H OR 146, I/A 20 (15.01.09).