Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2014 22 tarjetas
14/10/2014 Sec. I Ceses/Dimisiones Córdoba
Córdoba-410838

Ceses/dimisiones — 14/10/2014

Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: MORALES CRESPO MARTA. VsecrNoConsj: SILVA SABELL MARINA. Datos registrales. T 2393 , F 86, S 8, H CO 1801, I/A 58 (16.09.14).

23/09/2014 Sec. I Ceses/Dimisiones Córdoba
Córdoba-377225

Ceses/dimisiones — 23/09/2014

Ceses/Dimisiones. Consejero: MACHIN GONZALEZ RAFAEL;ROMERO SANCHEZ ROSARIO OLGA;ROMERO SANCHEZ MANUEL JESUS. Con.Delegado: ROMERO SANCHEZ ROSARIO OLGA. Presidente: ROMERO SANCHEZ ROSARIO OLGA. Consejero: CENTRO DE MANIP...

05/09/2014 Sec. I Nombramientos Córdoba
Córdoba-357016

Nombramientos — 05/09/2014

Nombramientos. Consejero: CENTRO DE MANIPULACION DE PRODUCTOS DE LA PESCA AN. Datos registrales. T 2393 , F 86, S 8, H CO 1801, I/A 57 (29.08.14).

07/07/2014 Sec. I Revocaciones Córdoba
Córdoba-279018

Revocaciones — 07/07/2014

Revocaciones. Apoderado: GARCIA ALJARO JUAN JOSE. Datos registrales. T 2393 , F 86, S 8, H CO 1801, I/A 56 (30.06.14).

22/05/2014 Sec. I Ceses/Dimisiones Córdoba
Córdoba-214311

Ceses/dimisiones — 22/05/2014

Ceses/Dimisiones. Consejero: PAGUILLO LOPEZ MANUEL FRANCISCO. Datos registrales. T 2393 , F 86, S 8, H CO 1801, I/A 55 (14.05.14).

31/03/2014 Sec. I Revocaciones Córdoba
Córdoba-141924

Revocaciones — 31/03/2014

Revocaciones. Apoderado: MORILLO LECO ALVARO. Nombramientos. Apoderado: PAGUILLO LOPEZ MANUEL FRANCISCO. Datos registrales. T 2393 , F 82, S 8, H CO 1801, I/A 54 (24.03.14).

19/03/2014 Sec. I Ampliación de capital Córdoba
Córdoba-123936

Ampliación de capital — 19/03/2014

Ampliación de capital. Suscrito: 234.360,00 Euros. Desembolsado: 234.360,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.617.000,00 Euros. Resultante Desembolsado: 1.617.000,00 Euros. Otros conceptos: Modificación de los artículos 5,...

24/01/2014 Sec. I Ceses/Dimisiones Córdoba
Córdoba-32888

Ceses/dimisiones — 24/01/2014

Ceses/Dimisiones. Presidente: MACHIN GONZALEZ FRANCISCO. Nombramientos. Presidente: ROMERO SANCHEZ ROSARIO OLGA. Datos registrales. T 2296 , F 148, S 8, H CO 1801, I/A 52 (20.01.14).

11/09/2013 Sec. I Reelecciones Córdoba
Córdoba-395329

Reelecciones — 11/09/2013

Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Reducción de capital. Importe reducción: 130.506,20 Euros. Resultante Suscrito: 1.567.979,60 Euros. Reducción de capital. Importe reducción: 185.339,60 Euros. Resultante Suscrito: 1.3...

06/08/2013 Sec. I Ceses/Dimisiones Córdoba
Córdoba-351971

Ceses/dimisiones — 06/08/2013

Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Man: ROMERO SANCHEZ ROSARIO OLGA. Nombramientos. Con.Delegado: ROMERO SANCHEZ ROSARIO OLGA. Datos registrales. T 2296 , F 146, S 8, H CO 1801, I/A 50 (30.07.13).

25/07/2013 Sec. I Ceses/Dimisiones Córdoba
Córdoba-333973

Ceses/dimisiones — 25/07/2013

Ceses/Dimisiones. Consejero: MACHIN RAMIREZ JUAN. Cons.Del.Man: MACHIN RAMIREZ JUAN. Datos registrales. T 2296 , F 146, S 8, H CO 1801, I/A 49 (18.07.13).

25/06/2013 Sec. I Nombramientos Córdoba
Córdoba-288764

Nombramientos — 25/06/2013

Nombramientos. Apoderado: MORILLO LECO ALVARO. Datos registrales. T 2296 , F 143, S 8, H CO 1801, I/A 48 (18.06.13). http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958

01/03/2013 Sec. I Ceses/Dimisiones Córdoba
Córdoba-103700

Ceses/dimisiones — 01/03/2013

Ceses/Dimisiones. Consejero: MACHIN GONZALEZ JUAN. Nombramientos. Consejero: ROMERO SANCHEZ MANUEL JESUS. Datos registrales. T 2296 , F 143, S 8, H CO 1801, I/A 46 (25.02.13).

01/03/2013 Sec. I Ampliación de capital Córdoba
Córdoba-103701

Ampliación de capital — 01/03/2013

Ampliación de capital. Suscrito: 399.139,40 Euros. Desembolsado: 399.139,40 Euros. Resultante Suscrito: 1.698.485,80 Euros. Resultante Desembolsado: 1.698.485,80 Euros. Datos registrales. T 2296 , F 143, S 8, H CO 1801,...

02/01/2013 Sec. I Revocaciones Córdoba
Córdoba-154

Revocaciones — 02/01/2013

Revocaciones. Apoderado: MACHIN GONZALEZ JUAN;MACHIN GONZALEZ FRANCISCO;MACHIN GONZALEZ RAFAEL;GOMEZ GARCIA JUAN;MARTINEZ DIAZ AMADOR;JURADO PEREZ EDUARDO. Nombramientos. Apoderado: GARCIA ALJARO JUAN JOSE. Datos regist...

02/01/2013 Sec. I Ceses/Dimisiones Córdoba
Córdoba-155

Ceses/dimisiones — 02/01/2013

Ceses/Dimisiones. Consejero: MATA CALLE JUAN CARLOS. Nombramientos. Consejero: PAGUILLO LOPEZ MANUEL FRANCISCO. Datos registrales. T 2296 , F 142, S 8, H CO 1801, I/A 44 (24.12.12).

20/08/2012 Sec. I Ceses/Dimisiones Córdoba
Córdoba-346674

Ceses/dimisiones — 20/08/2012

Ceses/Dimisiones. Secretario: GUERRA CARBAJO LUIS. Vicesecret.: ENCINAS CARPIZO OSCAR. Nombramientos. SecreNoConsj: MORALES CRESPO MARTA. VsecrNoConsj: SILVA SABELL MARINA. Datos registrales. T 615 , F 172, S 8, H CO 18...

14/06/2012 Sec. I Ceses/Dimisiones Córdoba
Córdoba-250976

Ceses/dimisiones — 14/06/2012

Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: MACHIN RAMIREZ JUAN. Nombramientos. Consejero: ROMERO SANCHEZ ROSARIO OLGA;MATA CALLE JUAN CARLOS. Cons.Del.Man: MACHIN RAMIREZ JUAN;ROMERO SANCHEZ ROSARIO OLGA. Datos registrales. T 615...

15/02/2012 Sec. I Reelecciones Córdoba
Córdoba-75236

Reelecciones — 15/02/2012

Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 615 , F 172, S 8, H CO 1801, I/A 40 ( 6.02.12).

18/03/2011 Sec. I Reelecciones Córdoba
Córdoba-123343

Reelecciones — 18/03/2011

Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 615 , F 171, S 8, H CO 1801, I/A 38 (10.03.11).

25/02/2010 Sec. I Reelecciones Córdoba
Córdoba-80933

Reelecciones — 25/02/2010

Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 615 , F 170, S 8, H CO 1801, I/A 35 (16.02.10).

19/02/2010 Sec. I Ceses/Dimisiones Córdoba
Córdoba-72079

Ceses/dimisiones — 19/02/2010

Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: MACHIN GONZALEZ FRANCISCO. Nombramientos. Con.Delegado: MACHIN GONZALEZ RAFAEL. Reelecciones. Secretario: GUERRA CARBAJO LUIS. Vicesecret.: ENCINAS CARPIZO OSCAR. Consejero: MACHIN GONZAL...