Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2018 22 tarjetas
27/07/2018 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-312860

Ceses/dimisiones — 27/07/2018

Ceses/Dimisiones. Consejero: HERNANDEZ RUIPEREZ DANIEL. Miem.Com.Ej.: HERNANDEZ RUIPEREZ DANIEL. Datos BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 144 Viernes 27 de julio de 2018 Pág. 33660 cve: BORME-A-2018-144-28 regi...

15/06/2018 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-253242

Ceses/dimisiones — 15/06/2018

Ceses/Dimisiones. Consejero: LORA TAMAYO D'OCON EMILIO;FOSSAS COLET ENRIC. Miem.Com.Ej.: PIRIZ DURAN SEGUNDO. Vicpres C.E: PIRIZ DURAN SEGUNDO. Vicepresid.: PIRIZ DURAN SEGUNDO. Nombramientos. Miem.Com.Ej.: FERNANDEZ DI...

21/03/2018 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-130956

Revocaciones — 21/03/2018

Revocaciones. Apoderado: GARCIA ESPINEL SUSANA;VERA VALLEJO MARIA;VERA VALLEJO MARIA. Apo.Manc.: GARCIA ESPINEL SUSANA. Nombramientos. Apoderado: GARCIA ESPINEL SUSANA;VERA VALLEJO MARIA. Datos registrales. T 33109 , F...

26/09/2017 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-383593

Ceses/dimisiones — 26/09/2017

Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: PAGES FITA JAUME. Consejero: MEDINA CHAO SALVADOR;SANZ MARTINEZ JOSE-MARIA. Miem.Com.Ej.: SANZ MARTINEZ JOSE-MARIA. Nombramientos. Consejero: COLLADO YURRITA MIGUEL-ANGEL;ARANDA RAMIREZ P...

10/05/2017 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-196795

Ceses/dimisiones — 10/05/2017

Ceses/Dimisiones. Secretario: GUERRERO GUERRERO MANUEL. Consejero: RAMIREZ I SARRIO DIDAC. Miem.Com.Ej.: RAMIREZ I SARRIO DIDAC. Consejero: REGIDOR GARCIA JOSE. Nombramientos. SecreNoConsj: SAENZ-DIEZ ROJAS TERESA. Vsec...

24/03/2017 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-133155

Revocaciones — 24/03/2017

Revocaciones. Apoderado: FERNANDEZ ESTEBAN MARIA DEL CARMEN. Datos registrales. T 33109 , F 106, S 8, H M 264916, I/A 104 (13.03.17).

19/10/2016 Sec. I Ampliación de capital Madrid
Madrid-420687

Ampliación de capital — 19/10/2016

Ampliación de capital. Suscrito: 600.000,00 Euros. Desembolsado: 600.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.392.778,80 Euros. Resultante Desembolsado: 2.392.778,80 Euros. Reducción de capital. Importe reducción: 1.495.486...

11/05/2016 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-203188

Ceses/dimisiones — 11/05/2016

Ceses/Dimisiones. Consejero: FUSTER VAN BENDEGEM JOSE MARIA. Datos registrales. T 33109 , F 103, S 8, H M 264916, I/A 100 ( 4.05.16). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 89 Miércoles 11 de mayo de 2016 Pág. 2184...

15/02/2016 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-67614

Ceses/dimisiones — 15/02/2016

Ceses/Dimisiones. Consejero: SAN FELIX GARCIA JAVIER;CEPEDA CARO JESUS;DE LA CALLE MARTIN ADELAIDA;GARCIA CANDELAS ENRIQUE;MORENO ALEGRE JOSE MANUEL. Nombramientos. Vicepresid.: PIRIZ DURAN SEGUNDO. Miem.Com.Ej.: PIRIZ...

16/10/2015 Sec. I Reelecciones Madrid
Madrid-416310

Reelecciones — 16/10/2015

Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 33109 , F 101, S 8, H M 264916, I/A 97 ( 8.10.15).

28/09/2015 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-390184

Ceses/dimisiones — 28/09/2015

Ceses/Dimisiones. Consejero: PEÑA SANCHEZ DE RIVERA DANIEL;CARRILLO MENENDEZ JOSE;GONZALEZ LODEIRO FRANCISCO;LAFUENTE LOPEZ JULIO. Nombramientos. Consejero: MURILLO VILLAR ALFONSO;GOMEZ SAL JOSE CARLOS;CLIMENT JORDA VIC...

28/09/2015 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-390183

Nombramientos — 28/09/2015

Nombramientos. Consejero: HERNANDEZ RUIPEREZ DANIEL. Fe de erratas: Se omitió por error en la inscripción 20 la publicación del nombramiento como consejero de don Daniel Hernández Ruipérez. Datos registrales. T 28900 ,...

30/12/2014 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-532692

Ceses/dimisiones — 30/12/2014

Ceses/Dimisiones. Pres.Com.Ej.: BOTIN SANZ DE SAUTUOLA Y GARCIA DE LOS RIOS EMILIO. Consejero: BOTIN SANZ DE SAUTUOLA Y GARCIA DE LOS RIOS EMILIO. Presidente: BOTIN SANZ DE SAUTUOLA Y GARCIA DE LOS RIOS EMILIO. Miem.Com...

27/08/2012 Sec. I Reelecciones Madrid
Madrid-355359

Reelecciones — 27/08/2012

Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 28900 , F 184, S 8, H M 264916, I/A 82 (13.08.12).

07/08/2012 Sec. I Modificaciones estatutarias Madrid
Madrid-331138

Modificaciones estatutarias — 07/08/2012

Modificaciones estatutarias. MODIFICADOS LOS ARTICULOS 1, 5, 7, 19, 20 Y 21 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. 7. Transmisión de Acciones/Participaciones.-. Datos registrales. T 28900 , F 181, S 8, H M 264916, I/A 79 (25.07.12).

07/08/2012 Sec. I Reducción de capital Madrid
Madrid-331139

Reducción de capital — 07/08/2012

Reducción de capital. Importe reducción: 1.742.230,40 Euros. Resultante Suscrito: 435.557,60 Euros. Datos registrales. T 28900 , F 182, S 8, H M 264916, I/A 80 (25.07.12).

07/08/2012 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-331140

Nombramientos — 07/08/2012

Nombramientos. Consejero: PEÑA SANCHEZ DE RIVERA DANIEL;CARRILLO MENENDEZ JOSE;COBACHO GOMEZ JOSE ANTONIO;GRAU I VIDAL FRANCESC XAVIER;MORCILLO SANCHEZ ESTEBAN JESUS;LORA TAMAYO D'OCON EMILIO;BERDUGO GOMEZ DE LA TORRE I...

13/06/2011 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-251932

Revocaciones — 13/06/2011

Revocaciones. Apoderado: BRAVO LIFANTE MANUEL;ARANZADI ELEJABEITIA PEDRO;SAGI-VELA GONZALEZ JAVIER;GARCIA ESPINEL SUSANA. Nombramientos. Apo.Man.Soli: SAGI-VELA GONZALEZ JAVIER;GARCIA ESPINEL SUSANA;VERA VALLEJO MARIA;A...

08/02/2011 Sec. I Fe de erratas: SE PUBLICO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 68 EL CESE COMO VICEPRESIDENTE DE DON FEDERICO GUTIERREZ SOLANA SALCEDO Madrid
Madrid-55217

Fe de erratas: se publico por error en la inscripcion 68 el cese como vicepresidente de don federico gutierrez solana salcedo — 08/02/2011

Fe de erratas: SE PUBLICO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 68 EL CESE COMO VICEPRESIDENTE DE DON FEDERICO GUTIERREZ SOLANA SALCEDO. Datos registrales. T 22213 , F 105, S 8, H M 264916, I/A 68 (27.12.10).

08/02/2011 Sec. I Otros conceptos: RECTIFICACION DE LA ESCRITURA OTORGADA ANTE EL NOTARIO DE MADRID, DON GONZALO SAUCA POLANCO, EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE2010, CON EL NUMERO DE PROTOCOLO 6278, QUE CAUSO LA INSCRIPCION 68& DE LA HOJA SOCIAL Madrid
Madrid-55218

Otros conceptos: rectificacion de la escritura otorgada ante el notario de madrid, don gonzalo sauca polanco, el dia 30 de noviembre de2010, con el numero de protocolo 6278, que causo la inscripcion 68& de la hoja social — 08/02/2011

Otros conceptos: RECTIFICACION DE LA ESCRITURA OTORGADA ANTE EL NOTARIO DE MADRID, DON GONZALO SAUCA POLANCO, EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE2010, CON EL NUMERO DE PROTOCOLO 6278, QUE CAUSO LA INSCRIPCION 68& DE LA HOJA SOCIA...

05/08/2010 Sec. I Reducción de capital Madrid
Madrid-308706

Reducción de capital — 05/08/2010

Reducción de capital. Importe reducción: 3.266.682,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.177.788,00 Euros. Datos registrales. T 22213 , F 102, S 8, H M 264916, I/A 64 (26.07.10).

31/05/2010 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-216476

Ceses/dimisiones — 31/05/2010

Ceses/Dimisiones. Consejero: ALONSO PEÑA JOSE RAMON;ZAPATERO GOMEZ VIRGILIO. Datos registrales. T 22213 , F 102, S 8, H M 264916, I/A 63 (19.05.10).