Actos destacados
Ceses/dimisiones — 27/07/2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: HERNANDEZ RUIPEREZ DANIEL. Miem.Com.Ej.: HERNANDEZ RUIPEREZ DANIEL. Datos BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 144 Viernes 27 de julio de 2018 Pág. 33660 cve: BORME-A-2018-144-28 regi...
Ceses/dimisiones — 15/06/2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: LORA TAMAYO D'OCON EMILIO;FOSSAS COLET ENRIC. Miem.Com.Ej.: PIRIZ DURAN SEGUNDO. Vicpres C.E: PIRIZ DURAN SEGUNDO. Vicepresid.: PIRIZ DURAN SEGUNDO. Nombramientos. Miem.Com.Ej.: FERNANDEZ DI...
Revocaciones — 21/03/2018
Revocaciones. Apoderado: GARCIA ESPINEL SUSANA;VERA VALLEJO MARIA;VERA VALLEJO MARIA. Apo.Manc.: GARCIA ESPINEL SUSANA. Nombramientos. Apoderado: GARCIA ESPINEL SUSANA;VERA VALLEJO MARIA. Datos registrales. T 33109 , F...
Ceses/dimisiones — 26/09/2017
Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: PAGES FITA JAUME. Consejero: MEDINA CHAO SALVADOR;SANZ MARTINEZ JOSE-MARIA. Miem.Com.Ej.: SANZ MARTINEZ JOSE-MARIA. Nombramientos. Consejero: COLLADO YURRITA MIGUEL-ANGEL;ARANDA RAMIREZ P...
Ceses/dimisiones — 10/05/2017
Ceses/Dimisiones. Secretario: GUERRERO GUERRERO MANUEL. Consejero: RAMIREZ I SARRIO DIDAC. Miem.Com.Ej.: RAMIREZ I SARRIO DIDAC. Consejero: REGIDOR GARCIA JOSE. Nombramientos. SecreNoConsj: SAENZ-DIEZ ROJAS TERESA. Vsec...
Revocaciones — 24/03/2017
Revocaciones. Apoderado: FERNANDEZ ESTEBAN MARIA DEL CARMEN. Datos registrales. T 33109 , F 106, S 8, H M 264916, I/A 104 (13.03.17).
Ampliación de capital — 19/10/2016
Ampliación de capital. Suscrito: 600.000,00 Euros. Desembolsado: 600.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.392.778,80 Euros. Resultante Desembolsado: 2.392.778,80 Euros. Reducción de capital. Importe reducción: 1.495.486...
Ceses/dimisiones — 11/05/2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: FUSTER VAN BENDEGEM JOSE MARIA. Datos registrales. T 33109 , F 103, S 8, H M 264916, I/A 100 ( 4.05.16). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 89 Miércoles 11 de mayo de 2016 Pág. 2184...
Ceses/dimisiones — 15/02/2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: SAN FELIX GARCIA JAVIER;CEPEDA CARO JESUS;DE LA CALLE MARTIN ADELAIDA;GARCIA CANDELAS ENRIQUE;MORENO ALEGRE JOSE MANUEL. Nombramientos. Vicepresid.: PIRIZ DURAN SEGUNDO. Miem.Com.Ej.: PIRIZ...
Reelecciones — 16/10/2015
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 33109 , F 101, S 8, H M 264916, I/A 97 ( 8.10.15).
Ceses/dimisiones — 28/09/2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: PEÑA SANCHEZ DE RIVERA DANIEL;CARRILLO MENENDEZ JOSE;GONZALEZ LODEIRO FRANCISCO;LAFUENTE LOPEZ JULIO. Nombramientos. Consejero: MURILLO VILLAR ALFONSO;GOMEZ SAL JOSE CARLOS;CLIMENT JORDA VIC...
Nombramientos — 28/09/2015
Nombramientos. Consejero: HERNANDEZ RUIPEREZ DANIEL. Fe de erratas: Se omitió por error en la inscripción 20 la publicación del nombramiento como consejero de don Daniel Hernández Ruipérez. Datos registrales. T 28900 ,...
Ceses/dimisiones — 30/12/2014
Ceses/Dimisiones. Pres.Com.Ej.: BOTIN SANZ DE SAUTUOLA Y GARCIA DE LOS RIOS EMILIO. Consejero: BOTIN SANZ DE SAUTUOLA Y GARCIA DE LOS RIOS EMILIO. Presidente: BOTIN SANZ DE SAUTUOLA Y GARCIA DE LOS RIOS EMILIO. Miem.Com...
Reelecciones — 27/08/2012
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 28900 , F 184, S 8, H M 264916, I/A 82 (13.08.12).
Modificaciones estatutarias — 07/08/2012
Modificaciones estatutarias. MODIFICADOS LOS ARTICULOS 1, 5, 7, 19, 20 Y 21 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. 7. Transmisión de Acciones/Participaciones.-. Datos registrales. T 28900 , F 181, S 8, H M 264916, I/A 79 (25.07.12).
Reducción de capital — 07/08/2012
Reducción de capital. Importe reducción: 1.742.230,40 Euros. Resultante Suscrito: 435.557,60 Euros. Datos registrales. T 28900 , F 182, S 8, H M 264916, I/A 80 (25.07.12).
Nombramientos — 07/08/2012
Nombramientos. Consejero: PEÑA SANCHEZ DE RIVERA DANIEL;CARRILLO MENENDEZ JOSE;COBACHO GOMEZ JOSE ANTONIO;GRAU I VIDAL FRANCESC XAVIER;MORCILLO SANCHEZ ESTEBAN JESUS;LORA TAMAYO D'OCON EMILIO;BERDUGO GOMEZ DE LA TORRE I...
Revocaciones — 13/06/2011
Revocaciones. Apoderado: BRAVO LIFANTE MANUEL;ARANZADI ELEJABEITIA PEDRO;SAGI-VELA GONZALEZ JAVIER;GARCIA ESPINEL SUSANA. Nombramientos. Apo.Man.Soli: SAGI-VELA GONZALEZ JAVIER;GARCIA ESPINEL SUSANA;VERA VALLEJO MARIA;A...
Fe de erratas: se publico por error en la inscripcion 68 el cese como vicepresidente de don federico gutierrez solana salcedo — 08/02/2011
Fe de erratas: SE PUBLICO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 68 EL CESE COMO VICEPRESIDENTE DE DON FEDERICO GUTIERREZ SOLANA SALCEDO. Datos registrales. T 22213 , F 105, S 8, H M 264916, I/A 68 (27.12.10).
Otros conceptos: rectificacion de la escritura otorgada ante el notario de madrid, don gonzalo sauca polanco, el dia 30 de noviembre de2010, con el numero de protocolo 6278, que causo la inscripcion 68& de la hoja social — 08/02/2011
Otros conceptos: RECTIFICACION DE LA ESCRITURA OTORGADA ANTE EL NOTARIO DE MADRID, DON GONZALO SAUCA POLANCO, EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE2010, CON EL NUMERO DE PROTOCOLO 6278, QUE CAUSO LA INSCRIPCION 68& DE LA HOJA SOCIA...
Reducción de capital — 05/08/2010
Reducción de capital. Importe reducción: 3.266.682,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.177.788,00 Euros. Datos registrales. T 22213 , F 102, S 8, H M 264916, I/A 64 (26.07.10).
Ceses/dimisiones — 31/05/2010
Ceses/Dimisiones. Consejero: ALONSO PEÑA JOSE RAMON;ZAPATERO GOMEZ VIRGILIO. Datos registrales. T 22213 , F 102, S 8, H M 264916, I/A 63 (19.05.10).