Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2018 24 tarjetas
20/09/2018 Sec. I Ceses/Dimisiones Zaragoza
Zaragoza-383947

Ceses/dimisiones — 20/09/2018

Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: ARIZNAVARRETA TEJEDOR MARTA. SecreNoConsj: CABEZA MURILLO CLAUDIA. L. Asesor: BIENDICHO GRACIA LUIS. Consejero: OLIVAN BELLOSTA GERARDO;GASTON MENAL MARTA;LANASPA SANTOLARIA LUIS FERNANDO...

18/04/2018 Sec. I Ceses/Dimisiones Zaragoza
Zaragoza-170541

Ceses/dimisiones — 18/04/2018

Ceses/Dimisiones. Consejero: FERNANDEZ CUELLO FERNANDO. Nombramientos. Consejero: CORPORACION EMPRESARIAL PUBLICA DE ARAGON SOCIEDAD. Datos registrales. T 4078 , F 58, S 8, H Z 41811, I/A 39 (11.04.18).

27/12/2017 Sec. I Nombramientos Zaragoza
Zaragoza-507921

Nombramientos — 27/12/2017

Nombramientos. Aud.Manc: CGM AUDITORES SL. Reelecciones. Aud.Manc: VILLALBA ENVID Y CIA AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA P. Datos registrales. T 4078 , F 57, S 8, H Z 41811, I/A 37 (19.12.17).

26/05/2017 Sec. I Cambio de domicilio social Zaragoza
Zaragoza-221231

Cambio de domicilio social — 26/05/2017

Cambio de domicilio social. PASEO Mª AGUSTIN, 36 (ZARAGOZA). Datos registrales. T 4078 , F 57, S 8, H Z 41811, I/A 36 (19.05.17).

25/05/2017 Sec. I Revocaciones Zaragoza
Zaragoza-218560

Revocaciones — 25/05/2017

Revocaciones. Apoderado: LOSTAO GARCIA BELEN. Nombramientos. Apoderado: LOSTAO GARCIA BELEN. Apo.Sol.: DE LA FUENTE GOMEZ FRANCISCO;LANASPA SANTOLARIA LUIS FERNANDO. Datos registrales. T 4078 , F 55, S 8, H Z 41811, I/A...

25/01/2017 Sec. I Reelecciones Zaragoza
Zaragoza-40004

Reelecciones — 25/01/2017

Reelecciones. Aud.Manc: VILLALBA ENVID Y CIA AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA P;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 4078 , F 55, S 8, H Z 41811, I/A 34 (17.01.17).

03/01/2017 Sec. I Reducción de capital Zaragoza
Zaragoza-3938

Reducción de capital — 03/01/2017

Reducción de capital. Importe reducción: 11.948.230,14 Euros. Resultante Suscrito: 2.987.057,54 Euros. Ampliación de capital. Capital: 1.500.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.487.057,54 Euros. Datos registrales. T 40...

12/07/2016 Sec. I Nombramientos Zaragoza
Zaragoza-291471

Nombramientos — 12/07/2016

Nombramientos. L. Asesor: BIENDICHO GRACIA LUIS. Datos registrales. T 4078 , F 55, S 8, H Z 41811, I/A 32 ( 4.07.16).

28/06/2016 Sec. I Nombramientos Zaragoza
Zaragoza-271877

Nombramientos — 28/06/2016

Nombramientos. Apoderado: LOSTAO GARCIA BELEN. Datos registrales. T 4078 , F 54, S 8, H Z 41811, I/A 31 (20.06.16).

14/06/2016 Sec. I Ceses/Dimisiones Zaragoza
Zaragoza-251547

Ceses/dimisiones — 14/06/2016

Ceses/Dimisiones. Consejero: ALOS LOPEZ ANA;LAFUENTE ASO FERNANDO. Datos registrales. T 4078 , F 53, S 8, H Z 41811, I/A 29 ( 3.06.16). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 112 Martes 14 de junio de 2016 Pág. 272...

14/06/2016 Sec. I Revocaciones Zaragoza
Zaragoza-251548

Revocaciones — 14/06/2016

Revocaciones. Apo.Sol.: LAHOZ PENON RAQUEL;DIEZ GRIJALBO SAMUEL;GARCIA FIGUERAS MANUEL;ARTAZOS HERCE ISABEL;RISUEÑO VILLANUEVA BELEN;LAGUARTA RECAJ MARIANO;BONILLA SAURAS MANUEL. Apoderado: FRANCH BARRABES JOSE MARIA. A...

01/03/2016 Sec. I Ceses/Dimisiones Zaragoza
Zaragoza-94411

Ceses/dimisiones — 01/03/2016

Ceses/Dimisiones. Consejero: FERNANDEZ DE ALARCON HERRERO RAFAEL. Presidente: FERNANDEZ DE ALARCON HERRERO RAFAEL. Consejero: CASABONA BERBERANA MARIA-ASUNCION;ANDREU MERELLES JESUS;TARDOS SOLANO JOSE-MARIA;VALDIVIA LOP...

01/03/2016 Sec. I Ceses/Dimisiones Zaragoza
Zaragoza-94412

Ceses/dimisiones — 01/03/2016

Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: PONCE MARTINEZ MARIA JOSE. Nombramientos. SecreNoConsj: CABEZA MURILLO CLAUDIA. Datos registrales. T 4078 , F 51, S 8, H Z 41811, I/A 25 (23.02.16).

01/03/2016 Sec. I Nombramientos Zaragoza
Zaragoza-94413

Nombramientos — 01/03/2016

Nombramientos. Aud.Manc: VILLALBA ENVID Y CIA AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA P;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 4078 , F 51, S 8, H Z 41811, I/A 26 (22.02.16).

01/03/2016 Sec. I Revocaciones Zaragoza
Zaragoza-94414

Revocaciones — 01/03/2016

Revocaciones. Apoderado: FERNANDEZ DE ALARCON HERRERO RAFAEL. Apo.Manc.: ANDREU MERELLES JESUS- FERNANDO. Nombramientos. Apoderado: DE LA FUENTE GOMEZ FRANCISCO. Datos registrales. T 4078 , F 52, S 8, H Z 41811, I/A 27...

01/03/2016 Sec. I Nombramientos Zaragoza
Zaragoza-94415

Nombramientos — 01/03/2016

Nombramientos. Consejero: OLIVAN BELLOSTA GERARDO. Datos registrales. T 4078 , F 53, S 8, H Z 41811, I/A 28 (22.02.16).

30/07/2015 Sec. I Reducción de capital Zaragoza
Zaragoza-317865

Reducción de capital — 30/07/2015

Reducción de capital. Importe reducción: 8.401.099,32 Euros. Resultante Suscrito: 14.935.287,68 Euros. Datos registrales. T 4078 , F 51, S 8, H Z 41811, I/A 23 (23.07.15). http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO...

07/01/2015 Sec. I Ampliación de capital Zaragoza
Zaragoza-3028

Ampliación de capital — 07/01/2015

Ampliación de capital. Capital: 2.200.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 23.336.387,00 Euros. Datos registrales. T 3798 , F 178, S 8, H Z 41811, I/A 22 (24.12.14).

01/09/2014 Sec. I Reelecciones Zaragoza
Zaragoza-351746

Reelecciones — 01/09/2014

Reelecciones. Aud.Manc: VILLALBA ENVID Y CIA AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA P;PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 3798 , F 178, S 8, H Z 41811, I/A 21 (21.08.14). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTI...

23/12/2013 Sec. I Ampliación de capital Zaragoza
Zaragoza-547542

Ampliación de capital — 23/12/2013

Ampliación de capital. Capital: 4.500.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 21.136.387,00 Euros. Datos registrales. T 3798 , F 178, S 8, H Z 41811, I/A 20 (11.12.13).

08/11/2013 Sec. I Ceses/Dimisiones Zaragoza
Zaragoza-478364

Ceses/dimisiones — 08/11/2013

Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA ALDEA JOSE-LEON. Nombramientos. Consejero: VALDIVIA LOPEZ PILAR. Datos registrales. T 3798 , F 178, S 8, H Z 41811, I/A 19 (30.10.13). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 214...

01/06/2012 Sec. I Nombramientos Zaragoza
Zaragoza-234704

Nombramientos — 01/06/2012

Nombramientos. Apo.Manc.: ANDREU MERELLES JESUS-FERNANDO. Otros conceptos: Modificado el poder objeto de la inscripción 10&, en cuantoa Don Manuel Tesa Avilla, por la 18&.Modificado el poder objeto de la inscripción 17&...

02/03/2012 Sec. I Ceses/Dimisiones Zaragoza
Zaragoza-104691

Ceses/dimisiones — 02/03/2012

Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: FAUQUIE BORRAJO DAVID. Nombramientos. SecreNoConsj: PONCE MARTINEZ MARIA JOSE. Datos registrales. T 3798 , F 174, S 8, H Z 41811, I/A 13 (20.02.12).

02/03/2012 Sec. I Ceses/Dimisiones Zaragoza
Zaragoza-104692

Ceses/dimisiones — 02/03/2012

Ceses/Dimisiones. Consejero: VICENTE BARRA ALFONSO. Presidente: VICENTE BARRA ALFONSO. Consejero: VAZQUEZ LOPEZ RAFAEL;TESA AVILLA MANUEL;AYUNTAMIENTO DE HUESCA;GARETA NAVARRO GEMA. Nombramientos. Consejero: FERNANDEZ D...