Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2026 19 tarjetas
21/01/2026 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-30513

Nombramientos — 21/01/2026

Nombramientos. Apo.Sol.: PEREA LUQUE JUAN RAFAEL;CALDERON MEDINA GONZALO. Apo.Man.Soli: PEREA LUQUE JUAN RAFAEL. Apo.Manc.: SUAREZ TRAMON ENRIQUE;BRAVO JIMENEZ ALBERTO. Datos registrales. S 8 , H M 272318, I/A 77 (15.01...

06/11/2019 Sec. I Reelecciones Madrid
Madrid-458706

Reelecciones — 06/11/2019

Reelecciones. Consejero: DE CASTRO RIBEIRO JOAQUIM FERNANDO;GARCIA PERLOIRO MORGADINHO JORGE MANUEL;FREITAS DUARTE VITOR MANUEL. Presidente: DE CASTRO RIBEIRO JOAQUIM FERNANDO. Secretario: FREITAS DUARTE VITOR MANUEL. D...

16/08/2019 Sec. I Reelecciones Madrid
Madrid-358236

Reelecciones — 16/08/2019

Reelecciones. Presidente: DE CASTRO RIBEIRO JOAQUIM FERNANDO. Datos registrales. T 38504 , F 84, S 8, H M 272318, I/A 63 ( 8.08.19).

16/08/2019 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-358237

Revocaciones — 16/08/2019

Revocaciones. Apoderado: SANZ GIMENEZ JOSE FLORENCIO;SANZ GIMENEZ JOSE FLORENCIO;SANZ GIMENEZ JOSE FLORENCIO;SANZ GIMENEZ JOSE FLORENCIO. Datos registrales. T 38504 , F 85, S 8, H M 272318, I/A 64 ( 8.08.19).

18/07/2019 Sec. I Reducción de capital Madrid
Madrid-311704

Reducción de capital — 18/07/2019

Reducción de capital. Importe reducción: 6.831.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 69.000,00 Euros. Datos registrales. T 38504 , F 84, S 8, H M 272318, I/A 62 (11.07.19).

17/05/2019 Sec. I Modificaciones estatutarias Madrid
Madrid-208897

Modificaciones estatutarias — 17/05/2019

Modificaciones estatutarias. Se modifica el artículo 9 de los estatutos sociales, y se incluye el artículo 9 Bis a los estatutos sociales.. Datos registrales. T 38504 , F 83, S 8, H M 272318, I/A 61 ( 9.05.19).

07/05/2019 Sec. I Sociedad unipersonal Madrid
Madrid-193223

Sociedad unipersonal — 07/05/2019

Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: SIERRA SPAIN MALAGA HOLDINGS SL. Datos registrales. T 38504 , F 83, S 8, H M 272318, I/A 60 (26.04.19).

14/02/2019 Sec. I Fusión por absorción Madrid
Madrid-69932

Fusión por absorción — 14/02/2019

Fusión por absorción. Sociedades absorbidas: PLAZA MAYOR PARQUE DE OCIO SA. Datos registrales. T 38504 , F 81, S 8, H M 272318, I/A 59 ( 7.02.19).

31/01/2019 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-45314

Nombramientos — 31/01/2019

Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 38504 , F 81, S 8, H M 272318, I/A 58 (24.01.19). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 21 Jueves 31 de enero de 2019 Pág. 4702 cve: BORME-A-2019-21-28

03/01/2019 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-1965

Revocaciones — 03/01/2019

Revocaciones. Apo.Manc.: DE CASTRO RIBEIRO JOAQUIM FERNANDO;MEDINA BARROSO DE FIGUEIREDO JOSE EDMUNDO;GARCIA PERLOIRO MORGADINHO JORGE MANUEL;SANZ GIMENEZ JOSE FLORENCIO;GAMBOA ABREU PESSEGUEIRO ALEXANDRE;DA SILVA FERRE...

26/04/2018 Sec. I Reelecciones Madrid
Madrid-183320

Reelecciones — 26/04/2018

Reelecciones. Consejero: GARCIA PERLOIRO MORGADINHO JORGE MANUEL. Secretario: DE CASTRO RIBEIRO JOAQUIM FERNANDO. Datos registrales. T 26737 , F 79, S 8, H M 272318, I/A 54 (18.04.18).

02/06/2017 Sec. I Reelecciones Madrid
Madrid-231093

Reelecciones — 02/06/2017

Reelecciones. Consejero: MEDINA BARROSO DE FIGUEIREDO JOSE-EDMUNDO. Presidente: MEDINA BARROSO DE FIGUEIREDO JOSE-EDMUNDO. Datos registrales. T 26737 , F 76, S 8, H M 272318, I/A 50 (25.05.17).

02/06/2017 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-231094

Nombramientos — 02/06/2017

Nombramientos. Apo.Manc.: DE CASTRO RIBEIRO JOAQUIM FERNANDO;MEDINA BARROSO DE FIGUEIREDO JOSE EDMUNDO;GARCIA PERLOIRO MORGADINHO JORGE MANUEL;SANZ GIMENEZ JOSE FLORENCIO;GAMBOA ABREU PESSEGUEIRO ALEXANDRE;DA SILVA FERR...

25/05/2016 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-221871

Nombramientos — 25/05/2016

Nombramientos. Consejero: DE CASTRO RIBEIRO JOAQUIM FERNANDO. Datos registrales. T 26737 , F 75, S 8, H M 272318, I/A 47 (17.05.16).

19/06/2015 Sec. I Reelecciones Madrid
Madrid-250219

Reelecciones — 19/06/2015

Reelecciones. Consejero: MEDINA BARROSO DE FIGUEIREDO JOSE-EDMUNDO. Datos registrales. T 26737 , F 72, S 8, H M 272318, I/A 43 (11.06.15).

19/06/2015 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-250220

Nombramientos — 19/06/2015

Nombramientos. Apo.Manc.: D'HOMMEE CAUPERS PEDRO JOSE;MEDINA BARROSO DE FIGUEIREDO JOSE EDMUNDO;DURAO FERNANDES ALEXANDRE MIGUEL;SANZ GIMENEZ JOSE FLORENCIO;GAMBOA ABREU PESEGUEIRO ALEXANDRE;DA SILVA FERREIRA FERNANDES...

07/06/2013 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-262591

Nombramientos — 07/06/2013

Nombramientos. Apo.Manc.: LOBAO ORGANISTA DA SOUSA MOTA ANA-CELESTE;D`HOMMEE CAUPERS PEDRO JOSE;MEDINA BARROSO DE FIGUEIREDO JOSE EDMUNDO;DURAO FERNANDES ALEXANDRE MIGUEL;SANZ GIMENEZ JOSE FLORENCIO;GAMBOA ABREU PESSEGU...

30/05/2012 Sec. I Reelecciones Madrid
Madrid-229235

Reelecciones — 30/05/2012

Reelecciones. Consejero: DURAO FERNANDES ALEXANDRE MIGUEL. Datos registrales. T 26737 , F 67, S 8, H M 272318, I/A 35 (18.05.12).

28/05/2009 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-244186

Revocaciones — 28/05/2009

Revocaciones. Apo.Manc.: CARVALHO MARQUES LUIS;DE CASTRO RIBEIRO JOAQUIM FERNANDO;SANZ GIMENEZ JOSE FLORENCIO;CORREIA MALTA VACAS RUI PEDRO;CARMONA E COSTA PORTELA ALVARO;MEDINA BARROSO DE FIGUEIREDO JOSE EDMUNDO;CORDEI...