Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2013 5 tarjetas
02/04/2013 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-152459

Revocaciones — 02/04/2013

Revocaciones. Apoderado: FALCONES JAQUOTOT BALDOMERO. Datos registrales. T 27866 , F 129, S 8, H M 502243, I/A 7 (21.03.13).

02/04/2013 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-152460

Nombramientos — 02/04/2013

Nombramientos. Apo.Sol.: BEJAR OCHOA JUAN. Datos registrales. T 27866 , F 129, S 8, H M 502243, I/A 8 (21.03.13).

01/07/2010 Sec. I Cambio de domicilio social Madrid
Madrid-261975

Cambio de domicilio social — 01/07/2010

Cambio de domicilio social. AVDA GENERAL PERON 36 (MADRID). Datos registrales. T 27866 , F 121, S 8, H M 502243, I/A 2 (18.06.10).

31/03/2010 Sec. I Revocaciones Murcia
Murcia-133957

Revocaciones — 31/03/2010

Revocaciones. Apoderado: JOSE HILARIO ORDOÑEZ SAINZ. Datos registrales. T 2569 , F 142, S 8, H MU 654, I/A 80 (23.03.10).

12/02/2009 Sec. I Fusión por absorción Murcia
Murcia-77657

Fusión por absorción — 12/02/2009

Fusión por absorción. Sociedades absorbidas: SEÑALIZACIONES LEVANTE SL. VIALES DE ANDALUCIA SL. MARCAS ANDALUZAS SL. Datos registrales. T 2569 , F 141, S 8, H MU 654, I/A 78 ( 4.02.09). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERC...