Actos destacados
Nombramientos — 03/12/2019
Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSE COOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 2814 , F 80, S 8, H PM 68642, I/A 19 (26.11.19).
Revocaciones — 31/05/2019
Revocaciones. Apo.Manc.: PENA COSTA MARCOS. Apo.Sol.: PENA COSTA MARCOS. Apo.Manc.: FERNANDEZ RAMOS GLORIA;FERNANDEZ RAMOS GLORIA. Apo.Sol.: FERNANDEZ RAMOS GLORIA;FERNANDEZ RAMOS GLORIA;FREIRE SENEN ALFONSO. Apo.Manc.:...
Reelecciones — 27/12/2018
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 2525 , F 216, S 8, H PM 68642, I/A 16 (18.12.18).
Revocaciones — 08/08/2016
Revocaciones. Apo.Sol.: FLORES CORCORAN JULIA;FLORES CORCORAN JULIA. Datos registrales. T 2525 , F 216, S 8, H PM 68642, I/A 14 (29.07.16).
Nombramientos — 29/06/2016
Nombramientos. Apo.Man.Soli: CAÑELLAS MARTORELL ADA MAGDALENA. Apo.Manc.: MILLOTT REMY JOHN;FERNANDEZ RAMOS GLORIA. Datos registrales. T 2525 , F 215, S 8, H PM 68642, I/A 13 (22.06.16).
Revocaciones — 28/06/2016
Revocaciones. Apoderado: FREIRE SENEN ALFONSO. Apo.Man.Soli: ENTWISLE CHARLES NICHOLAS PETER;FREIRE SENEN ALFONSO. Datos registrales. T 2525 , F 215, S 8, H PM 68642, I/A 12 (21.06.16).
Nombramientos — 21/06/2016
Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 2525 , F 215, S 8, H PM 68642, I/A 11 (14.06.16).
Revocaciones — 13/03/2014
Revocaciones. Apo.Sol.: AVIA ROSSELLO MARIA JOSEP;AVIA ROSSELLO MARIA JOSEP. Apo.Manc.: JULVE BRAÑAS ALBERT. Apo.Sol.: JULVE BRAÑAS ALBERT;FELIU MARTORELL ANTONIA. Apo.Manc.: FELIU MARTORELL ANTONIA;FELIU MARTORELL ANTO...
Nombramientos — 04/04/2013
Nombramientos. Apo.Manc.: FERNANDEZ RAMOS GLORIA;FERNANDEZ RAMOS GLORIA;WILKINSON TRACEY MICHELLE;MORA SARAVIA JOSE IGNACIO;FREIRE SENEN ALFONSO;FELIU MARTORELL ANTONIA;MILLOTT REMY JOHN;PENA COSTA MARCOS;FELIU MARTOREL...
Ceses/dimisiones — 20/03/2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: MORA SARAVIA JOSE IGNACIO;ENTWISLE CHARLES NICHOLAS PETER;MILLOTT REMY JOHN. Secretario: ENTWISLE CHARLES NICHOLAS PETER. Presidente: MILLOTT REMY JOHN. Cons.Del.Sol: MILLOTT REMY JOHN. Nomb...
Ceses/dimisiones — 25/10/2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: CAPO GIOL ENRIC. Datos registrales. T 2501 , F 128, S 8, H PM 68642, I/A 7 (16.10.12).
Ceses/dimisiones — 04/09/2012
Ceses/Dimisiones. Secretario: SISK DARREN. Cons.Del.Sol: SISK DARREN. Consejero: SISK DARREN. Nombramientos. Consejero: ENTWISLE CHARLES NICHOLAS PETER. Secretario: ENTWISLE CHARLES NICHOLAS PETER. Datos registrales. T...
Nombramientos — 27/06/2012
Nombramientos. Apoderado: AVIA ROSSELLO MARIA JOSEP. Datos registrales. T 2481 , F 57, S 8, H PM 68642, I/A 2 (18.06.12).
Nombramientos — 27/06/2012
Nombramientos. Apo.Man.Soli: ENTWISLE CHARLES NICHOLAS PETER;FELIU MARTORELL ANTONIA MARIA;FREIRE SENEN ALFONSO. Datos registrales. T 2481 , F 57, S 8, H PM 68642, I/A 3 (18.06.12).
Nombramientos — 27/06/2012
Nombramientos. Apoderado: FREIRE SENEN ALFONSO. Datos registrales. T 2501 , F 128, S 8, H PM 68642, I/A 4 (18.06.12).
Modificaciones estatutarias — 27/06/2012
Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: Artículo 25º.- El ejercicio social comenzará el día 1 de septiembre de cada año y terminará el día 31 de agosto del año siguiente. Por excepción el primer ejercici...
Constitución — 29/12/2011
Constitución. Comienzo de operaciones: 29.11.11. Objeto social: Trabajos de mantenimiento, reparación, pintura y custodia de embarcacionesde todas clases. Compra y venta de materiales propios para la realización de trab...