Actos destacados
Modificaciones estatutarias — 14/01/2019
Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: Relativo al objeto social . Ampliacion del objeto social. Ampliado en cuanto BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 8 Lunes 14 de enero de 2019 Pág. 1199 cve:...
Ceses/dimisiones — 21/08/2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: LOPEZ SANCHEZ LUIS. Presidente: LOPEZ SANCHEZ LUIS. Nombramientos. Consejero: LOPEZ RICO LUIS. Presidente: LOPEZ RICO LUIS. Modificaciones estatutarias. 22. Otros.-. Datos registrales. T 256...
Revocaciones — 26/07/2018
Revocaciones. Apo.Man.Soli: LOPEZ PENA ALFONSO MANUEL. Apo.Manc.: LOPEZ PENA ALFONSO MANUEL. Apo.Sol.: LOPEZ PENA ALFONSO MANUEL. Datos registrales. T 2562 , F 172, S 8, H C 28360, I/A 33 (18.07.18).
Reelecciones — 29/01/2018
Reelecciones. Auditor: AUDITORIA Y DIAGNOSTICO EMPRESARIAL S.A. Datos registrales. T 2562 , F 171, S 8, H C 28360, I/A 32 (18.01.18).
Nombramientos — 14/12/2016
Nombramientos. Consejero: SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA. Datos registrales. T 2562 , F 171, S 8, H C 28360, I/A 31 ( 7.12.16).
Ampliación de capital — 18/08/2016
Ampliación de capital. Suscrito: 2.000.007,80 Euros. Desembolsado: 2.000.007,80 Euros. Resultante Suscrito: 5.759.322,90 Euros. Resultante Desembolsado: 5.759.322,90 Euros. Modificaciones estatutarias. Artículo de los e...
Ampliación de capital — 18/08/2016
Ampliación de capital. Suscrito: 799.991,10 Euros. Desembolsado: 799.991,10 Euros. Resultante Suscrito: 6.559.314,00 Euros. Resultante Desembolsado: 6.559.314,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Artículo de los estat...
Nombramientos — 20/01/2016
Nombramientos. Apo.Man.Soli: ALONSO LAFUENTE MANUEL. Apo.Manc.: VAZQUEZ ESTRAVIZ CELESTINO;MENDEZ LINARES SANTIAGO;IGLESIAS DIAZ MANUEL;DE ARTAZA VARASA ALBERTO;LAZARO ALCANTARA JOSE LUIS;ALONSO LAFUENTE MANUEL. Datos r...
Cancelaciones de oficio de nombramientos — 14/09/2015
Cancelaciones de oficio de nombramientos. Cons.Del.Sol: LOPEZ SANCHEZ EMILIO;LOPEZ SANCHEZ LUIS. Reelecciones. Secretario: PASCUAL DE MIGUEL JULIO. Datos registrales. T 2562 , F 169, S 8, H C 28360, I/A 27 ( 7.09.15).
Nombramientos — 12/05/2015
Nombramientos. Apo.Sol.: VAZQUEZ ESTRAVIZ CELESTINO;LAZARO ALCANTARA JOSE LUIS;LOPEZ PENA ALFONSO MANUEL. Datos registrales. T 2562 , F 169, S 8, H C 28360, I/A 26 (30.04.15).
Modificaciones estatutarias — 03/07/2014
Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: Relativo al objeto social. Ampliacion del objeto social. Ampliado en cuanto a: Instalación, desarrollo, operación y gestión de plantas de producción de energía tér...
Nombramientos — 25/06/2014
Nombramientos. Auditor: AUDITORIA Y DIAGNOSTICO EMPRESARIAL SA. Datos registrales. T 2562 , F 168, S 8, H C 28360, I/A 24 (17.06.14).
Nombramientos — 13/06/2012
Nombramientos. Apo.Man.Soli: DE ARTAZA VARASA ALBERTO. Apo.Manc.: VAZQUEZ ESTRAVIZ CELESTINO;MENDEZ LINARES SANTIAGO;IGLESIAS DIAZ MANUEL;LOPEZ PENA ALFONSO MANUEL. Datos registrales. T 2562 , F 167, S 8, H C 28360, I/A...
Nombramientos — 17/05/2012
Nombramientos. Apoderado: SILVA MUÑIZ IVAN. Datos registrales. T 2562 , F 167, S 8, H C 28360, I/A 22 ( 4.05.12).
Modificaciones estatutarias — 01/12/2011
Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: Relativo al objeto social. Ampliacion del objeto social. Ampliado en cuanto a "Reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria e instalaciones de centrales...
Reelecciones — 01/12/2011
Reelecciones. Auditor: AUDITORIA Y DIAGNOSTICO EMPRESARIAL SA. Datos registrales. T 2562 , F 167, S 8, H C 28360, I/A 21 (23.11.11).
Ceses/dimisiones — 05/10/2009
Ceses/Dimisiones. Secretario: PASCUAL DE MIGUEL JULIO. Nombramientos. Secretario: PASCUAL DE MIGUEL JULIO. Reelecciones. Consejero: LOPEZ SANCHEZ EMILIO;LOPEZ SANCHEZ LUIS;LOPEZ FERNANDEZ ESTEBAN. Vicesecret.: LOPEZ FER...