Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2013 20 tarjetas
09/07/2013 Sec. I Transformación de sociedad Zaragoza
Zaragoza-312491

Transformación de sociedad — 09/07/2013

Transformación de sociedad. Denominación y forma adoptada: PIKOLIN SL. Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: GRUPOPIKOLIN SL. Nombramientos. Consejero: SOLANS SOLANS ALFONSO. Presidente: SOLANS SOLANS ALFONSO. Consejero: SOLANS...

17/04/2013 Sec. I Nombramientos Zaragoza
Zaragoza-182394

Nombramientos — 17/04/2013

Nombramientos. Apoderado: MUÑOZ PEREIRA DAVID. Datos registrales. T 3940 , F 145, S 8, H Z 864, I/A 190 ( 9.04.13).

18/02/2013 Sec. I Revocaciones Zaragoza
Zaragoza-80688

Revocaciones — 18/02/2013

Revocaciones. Apoderado: DE LA CALLE ESTELA JUAN. Datos registrales. T 3940 , F 145, S 8, H Z 864, I/A 189 ( 8.02.13).

10/01/2013 Sec. I Reelecciones Zaragoza
Zaragoza-11506

Reelecciones — 10/01/2013

Reelecciones. Auditor: CGM AUDITORES SL. Datos registrales. T 3940 , F 145, S 8, H Z 864, I/A 188 (31.12.12).

24/12/2012 Sec. I Revocaciones Zaragoza
Zaragoza-535793

Revocaciones — 24/12/2012

Revocaciones. Apoderado: MENDIZABAL JORAJURIA JOSE MARIA. Datos registrales. T 3940 , F 145, S 8, H Z 864, I/A 187 (17.12.12).

10/12/2012 Sec. I Nombramientos Zaragoza
Zaragoza-509827

Nombramientos — 10/12/2012

Nombramientos. Apoderado: SOLANS SOLANS ALFONSO. Datos registrales. T 3063 , F 225, S 8, H Z 864, I/A 186 (28.11.12). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 235 Lunes 10 de diciembre de 2012 Pág. 55152 cve: BORME-A...

03/12/2012 Sec. I Nombramientos Zaragoza
Zaragoza-497695

Nombramientos — 03/12/2012

Nombramientos. Apo.Manc.: FARAONE MICHELE-PAOLO;CAÑIZARES LUIS-FERNANDO;CASEIRO PORTASIO CUSTODIO- MANUEL. Datos registrales. T 3063 , F 225, S 8, H Z 864, I/A 185 (21.11.12).

16/05/2012 Sec. I Nombramientos Zaragoza
Zaragoza-208002

Nombramientos — 16/05/2012

Nombramientos. Apo.Sol.: PARDOS FRANCO JOSE-MANUEL. Datos registrales. T 3063 , F 222, S 8, H Z 864, I/A 183 ( 2.05.12).

04/05/2012 Sec. I Revocaciones Zaragoza
Zaragoza-193517

Revocaciones — 04/05/2012

Revocaciones. Apoderado: BUIL ESEVERRI IGNACIO. Datos registrales. T 3063 , F 222, S 8, H Z 864, I/A 182 (19.04.12).

26/03/2012 Sec. I Revocaciones Zaragoza
Zaragoza-140068

Revocaciones — 26/03/2012

Revocaciones. Apoderado: RUBIO MILLAN INMACULADA. Datos registrales. T 3063 , F 222, S 8, H Z 864, I/A 181 (13.03.12).

01/12/2011 Sec. I Revocaciones Zaragoza
Zaragoza-482096

Revocaciones — 01/12/2011

Revocaciones. Apoderado: BASCUAS ASTA CARLOS. Datos registrales. T 3063 , F 222, S 8, H Z 864, I/A 180 (18.11.11).

22/09/2011 Sec. I Revocaciones Zaragoza
Zaragoza-381845

Revocaciones — 22/09/2011

Revocaciones. Apoderado: ALTOLAGUIRRE ABRIL JOSE-ANTONIO;ALTOLAGUIRRE ABRIL JOSE-ANTONIO. Datos registrales. T 3063 , F 222, S 8, H Z 864, I/A 179 (13.09.11).

30/05/2011 Sec. I Otros conceptos: Se amplia las facultades del poder objeto de la inscripción120& Zaragoza
Zaragoza-231006

Otros conceptos: se amplia las facultades del poder objeto de la inscripción120& — 30/05/2011

Otros conceptos: Se amplia las facultades del poder objeto de la inscripción120&. a favor de DON JOSE MARIA CEREZO PORROCHE. Datos registrales. T 3063 , F 222, S 8, H Z 864, I/A 178 (18.05.11).

18/05/2011 Sec. I Otros conceptos: Ampliado el poder conferido a favor de DON ENRIQUE OCEJO MARIN, -que motivó la nscripción 175& Zaragoza
Zaragoza-212647

Otros conceptos: ampliado el poder conferido a favor de don enrique ocejo marin, -que motivó la nscripción 175& — 18/05/2011

Otros conceptos: Ampliado el poder conferido a favor de DON ENRIQUE OCEJO MARIN, -que motivó la nscripción 175&. Datos registrales. T 3063 , F 222, S 8, H Z 864, I/A 176 ( 6.05.11).

18/05/2011 Sec. I Nombramientos Zaragoza
Zaragoza-212648

Nombramientos — 18/05/2011

Nombramientos. Apoderado: DE LA CALLE ESTELA JUAN. Datos registrales. T 3063 , F 222, S 8, H Z 864, I/A 177 ( 6.05.11).

30/08/2010 Sec. I Revocaciones Zaragoza
Zaragoza-335389

Revocaciones — 30/08/2010

Revocaciones. Apoderado: ASENSIO VARGAS JORGE;FERNANDEZ ABAD MANUEL. Datos registrales. T 3063 , F 221, S 8, H Z 864, I/A 171 (18.08.10).

09/02/2010 Sec. I Revocaciones Zaragoza
Zaragoza-55887

Revocaciones — 09/02/2010

Revocaciones. Auditor: AUDIHISPANA GRANT THORNTON SL. Nombramientos. Auditor: CGM AUDITORES SL. Datos registrales. T 3063 , F 221, S 8, H Z 864, I/A 170 (28.01.10).

12/08/2009 Sec. I Revocaciones Zaragoza
Zaragoza-355091

Revocaciones — 12/08/2009

Revocaciones. Apoderado: BUENO LIDON LUIS FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 3063 , F 220, S 8, H Z 864, I/A 169 ( 3.08.09).

25/02/2009 Sec. I Revocaciones Zaragoza
Zaragoza-100906

Revocaciones — 25/02/2009

Revocaciones. Apoderado: MORALES SALAZAR JOAQUIN. Datos registrales. T 3063 , F 220, S 8, H Z 864, I/A 167 (13.02.09).

25/02/2009 Sec. I Nombramientos Zaragoza
Zaragoza-100907

Nombramientos — 25/02/2009

Nombramientos. Apoderado: OCEJO MARIN ENRIQUE. Datos registrales. T 3063 , F 220, S 8, H Z 864, I/A 168 (13.02.09).