Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2015 4 tarjetas
05/08/2015 Sec. I Revocaciones Barcelona
Barcelona-325296

Revocaciones — 05/08/2015

Revocaciones. LIQUID.MANC.: CARRATALA ALASTRUEY FRANCISCO JAVIER;GIMENEZ BINDER SERGIO;WILFRIED LUDWIG EUL;MARTINEZ NAVACERRADA MIGUEL LUIS;CATA FABREGAS PEDRO. Extinción. Datos registrales. T 40365 , F 83, S 8, H B 716...

10/06/2014 Sec. I Revocaciones Barcelona
Barcelona-242301

Revocaciones — 10/06/2014

Revocaciones. LIQUID.MANC.: ESCUDE FORNES JOSE ORIOL;LOPEZ MARTINEZ JOSE MARIA. Nombramientos. LIQUID.MANC.: MARTINEZ NAVACERRADA MIGUEL LUIS;CATA FABREGAS PEDRO. Cambio de domicilio social. PS DE GRACIA Num.11 ESC.B P....

27/01/2012 Sec. I Cambio de domicilio social Barcelona
Barcelona-41708

Cambio de domicilio social — 27/01/2012

Cambio de domicilio social. AV DIAGONAL,530-532 P.3 (BARCELONA). Datos registrales. T 40365 , F 83, S 8, H B 71646, I/A 109 (18.01.12).

30/10/2009 Sec. I Revocaciones Barcelona
Barcelona-454527

Revocaciones — 30/10/2009

Revocaciones. APODERADO: JOHN MITCHELL HORNE. Datos registrales. T 40365 , F 81, S 8, H B 71646, I/A 106 (20.10.09).