Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2014 19 tarjetas
14/10/2014 Sec. I Transformación de sociedad Barcelona
Barcelona-409992

Transformación de sociedad — 14/10/2014

Transformación de sociedad. Denominación y forma adoptada: PAYMA COTAS SL. Datos registrales. T 43688 , F 67, S 8, H B 273483, I/A 164 ( 6.10.14).

12/08/2013 Sec. I Revocaciones Barcelona
Barcelona-358815

Revocaciones — 12/08/2013

Revocaciones. APODERADO: QUIROS FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 43688 , F 65, S 8, H B 273483, I/A 160 ( 2.08.13).

18/06/2013 Sec. I Ampliación de capital Barcelona
Barcelona-277403

Ampliación de capital — 18/06/2013

Ampliación de capital. Suscrito: 2.999.850,00 Euros. Desembolsado: 2.999.850,00 Euros. Resultante Suscrito: 6.695.850,00 Euros. Resultante Desembolsado: 6.695.850,00 Euros. Datos registrales. T 43688 , F 62, S 8, H B 27...

12/04/2013 Sec. I Nombramientos Barcelona
Barcelona-172719

Nombramientos — 12/04/2013

Nombramientos. APODERADO: GARCIA RODRIGUEZ ALVARO;CARNACEA GUERRERO JOSE LUIS. Datos registrales. T 43104 , F 79, S 8, H B 273483, I/A 153 ( 3.04.13).

26/03/2013 Sec. I Revocaciones Barcelona
Barcelona-145281

Revocaciones — 26/03/2013

Revocaciones. APODERADO: DESMONTS SIERRA CRISTINA GABRIELA. Datos registrales. T 43104 , F 78, S 8, H B 273483, I/A 149 (19.03.13).

26/03/2013 Sec. I Nombramientos Barcelona
Barcelona-145282

Nombramientos — 26/03/2013

Nombramientos. APODERADO: SOLER DEL RIO LLUIS. Datos registrales. T 43104 , F 78, S 8, H B 273483, I/A 150 (19.03.13). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 58 Martes 26 de marzo de 2013 Pág. 15338 cve: BORME-A-20...

26/03/2013 Sec. I Nombramientos Barcelona
Barcelona-145283

Nombramientos — 26/03/2013

Nombramientos. APODERADO: SOLER DEL RIO LLUIS;MARTIN GALLARDO SEBASTIAN;CASAMAYOR TOLEDO ALICIA. Datos registrales. T 43104 , F 79, S 8, H B 273483, I/A 151 (19.03.13).

26/03/2013 Sec. I Revocaciones Barcelona
Barcelona-145284

Revocaciones — 26/03/2013

Revocaciones. APODERADO: CASO GARCIA FRANCISCO JOSE. Datos registrales. T 43104 , F 79, S 8, H B 273483, I/A 152 (19.03.13).

04/03/2013 Sec. I Revocaciones Barcelona
Barcelona-105319

Revocaciones — 04/03/2013

Revocaciones. APODERADO: MORALES FUENTECILLA ANGEL RICARDO;PINEDA GONZALEZ EDUARDO. Datos registrales. T 43104 , F 78, S 8, H B 273483, I/A 148 (20.02.13).

10/10/2012 Sec. I Modificación de poderes Barcelona
Barcelona-413486

Modificación de poderes — 10/10/2012

Modificación de poderes. APODERADO: ARRARTE RUBIO CARLOS;CASO GARCIA FRANCISCO JOSE;CHAMORRO MERA OSCAR;MORALES FUENTECILLA ANGEL RICARDO;URRIZA PARROQUE FRANCISCO;ZAPARDIEL GARCIA JUAN;ZAPATA SOLA MIGUEL JESUS. Datos r...

23/08/2012 Sec. I Nombramientos Barcelona
Barcelona-351682

Nombramientos — 23/08/2012

Nombramientos. APODERADO: MARTIN PEÑASCO CACERES CARLOS. Datos registrales. T 43104 , F 76, S 8, H B 273483, I/A 145 ( 9.08.12).

11/07/2012 Sec. I Revocaciones Barcelona
Barcelona-292613

Revocaciones — 11/07/2012

Revocaciones. APODERADO: ARDINES SAMPEDRO JOSE MIGUEL;MORALES FUENTECILLA ANGEL RICARDO;SOLER DEL RIO LLUIS;JIMENEZ RAMIREZ MANUEL;SOTOMAYOR BUSTAMANTE JOSE LUIS;MUÑOZ HERRERA FRANCISCO JOSE;RISUEÑO ALTIER JORGE;PLANAS...

11/07/2012 Sec. I Nombramientos Barcelona
Barcelona-292696

Nombramientos — 11/07/2012

Nombramientos. APODERADO: QUIROS FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 43104 , F 73, S 8, H B 273483, I/A 143 (28.06.12).

11/07/2012 Sec. I Nombramientos Barcelona
Barcelona-292698

Nombramientos — 11/07/2012

Nombramientos. APODERADO: COTOS PEREIRA FRANCISCO. Datos registrales. T 43104 , F 74, S 8, H B 273483, I/A 144 (28.06.12).

03/05/2012 Sec. I Cambio de objeto social Barcelona
Barcelona-189782

Cambio de objeto social — 03/05/2012

Cambio de objeto social. SE AMPLIA EN: K) ENSAYOS Y ANALISIS DE LABORATORIO Y DE CAMPO RELATIVOS A LA REALIZACION DE ESTUDIOS GEOLOGICOS,HIDROGEOLOGICOS Y GEOMETRICOS Y PARA EL CONTROL DE OBRA Y MATERIALES UTILIZADOS EN...

09/03/2012 Sec. I Revocaciones Barcelona
Barcelona-113692

Revocaciones — 09/03/2012

Revocaciones. ADM.SOLIDAR.: PATRICK AUBRY;BLAY BORCH CARLOS;PERAL AMOROS ANTONIO. Nombramientos. ADM.UNICO: MANGLANO BORSO DI CARMINATI JOSE LUIS. Modificaciones estatutarias. ARTS.25 Y 28:MODIFICACION EN LA ESTRUCTURA...

16/08/2011 Sec. I Nombramientos Barcelona
Barcelona-338040

Nombramientos — 16/08/2011

Nombramientos. APODERADO: ITURMENDI NAVARRO GONZALO. Datos registrales. T 41820 , F 136, S 8, H B 273483, I/A 122 ( 3.08.11).

14/01/2011 Sec. I Nombramientos Barcelona
Barcelona-13993

Nombramientos — 14/01/2011

Nombramientos. AUDIT.CUENT.: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 41820 , F 136, S 8, H B 273483, I/A 120 ( 3.01.11).

18/02/2010 Sec. I Cambio de domicilio social Barcelona
Barcelona-70113

Cambio de domicilio social — 18/02/2010

Cambio de domicilio social. AV CAN FATJO DELS AURONS,9,PQ.EMP.A-7 (SANT CUGAT DEL VALLES). Datos registrales. T 41504 , F 70, S 8, H B 273483, I/A 102 ( 8.02.10).