Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2018 14 tarjetas
11/10/2018 Sec. I Disolución Madrid
Madrid-410064

Disolución — 11/10/2018

Disolución. Fusion. Extinción. Datos registrales. T 37011 , F 40, S 8, H M 661272, I/A 6 ( 4.10.18).

26/06/2018 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-267221

Revocaciones — 26/06/2018

Revocaciones. Apo.Manc.: BOLINSKI PIOTR. Apoderado: BOLINSKI PIOTR. Nombramientos. Apoderado: PIECHNA KRZYSZTOF. Datos registrales. T 37011 , F 34, S 8, H M 661272, I/A 5 (15.06.18).

23/05/2018 Sec. I Cambio de domicilio social Madrid
Madrid-217899

Cambio de domicilio social — 23/05/2018

Cambio de domicilio social. C/ ENRIQUE GRANADOS 6, EDIFICIO B, NIVEL 2, OFICIN (POZUELO DE ALARCON). Datos registrales. T 37011 , F 34, S 8, H M 661272, I/A 3 (10.05.18).

23/05/2018 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-217900

Nombramientos — 23/05/2018

Nombramientos. Apoderado: PRIEGO LUQUE MARIA DOLORES;SIMON MONTELONGO JOSE MANUEL. Datos registrales. T 37011 , F 34, S 8, H M 661272, I/A 4 (10.05.18).

10/05/2017 Sec. I Revocaciones Lleida
Lleida-196372

Revocaciones — 10/05/2017

Revocaciones. Apoderado: ESCORIAL SENANTE IÑIGO. Nombramientos. Apoderado: ROSADO ALCANTARA FRANCISCO. Datos registrales. T 631 , F 172, S 8, H L 11663, I/A 27 ( 3.05.17).

15/03/2017 Sec. I Nombramientos Lleida
Lleida-119368

Nombramientos — 15/03/2017

Nombramientos. Apo.Manc.: JAÑEZ BARCENAS MARIA DEL CARMEN;MONEDERO MATEO ALBERTO. Datos registrales. T 629 , F 142, S 8, H L 11663, I/A 26 ( 7.03.17).

03/03/2016 Sec. I Nombramientos Lleida
Lleida-100698

Nombramientos — 03/03/2016

Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ-PICAZO RODRIGUEZ MARIA. Datos registrales. T 625 , F 8, S 8, H L 11663, I/A 23 (24.02.16).

11/11/2015 Sec. I Nombramientos Lleida
Lleida-453538

Nombramientos — 11/11/2015

Nombramientos. Apo.Manc.: GORGUES CARNICE DAVID;PATO-CASTEL TADEO MARIA ELENA;ROIGE TAMARIT JOSE;CAMPA PARRAMON GLORIA;CONTRERAS JAIMES GLADYS MARIA;MUR MORELLO NURIA;SANJUAN MATONS LOURDES;NURIA BODET GOMEZ;CANALES MIL...

25/05/2015 Sec. I Ceses/Dimisiones Lleida
Lleida-210671

Ceses/dimisiones — 25/05/2015

Ceses/Dimisiones. Presidente: KENT WINEGAR STEVEN. Consejero: KENT WINEGAR STEVEN;MCGOVERN HENRY JOSEPH. Nombramientos. Consejero: COLLADO RODRIGUEZ JESUS. Presidente: BOLINSKI PIOTR. Otros conceptos: Fijación en tres d...

27/09/2013 Sec. I Ceses/Dimisiones Lleida
Lleida-415940

Ceses/dimisiones — 27/09/2013

Ceses/Dimisiones. Consejero: DE LA PEDRAJA ANGULO ENRIQUE. M.Com.Ej: BOLINSKI PIOTR;RANDALL CHANDLER MARK;KENT WINEGAR STEVEN. Otros conceptos: Refundidos los Estatutos Sociales de la Entidad. Datos registrales. T 623 ,...

24/07/2013 Sec. I Ceses/Dimisiones Lleida
Lleida-332206

Ceses/dimisiones — 24/07/2013

Ceses/Dimisiones. Vicesecret.: SANCHEZ MONTALBAN JOSE. Nombramientos. VsecrNoConsj: BOCOS MARTIN MARIA TERESA. Datos registrales. T 623 , F 30, S 8, H L 11663, I/A 19 (17.07.13).

24/02/2012 Sec. I Modificaciones estatutarias Lleida
Lleida-91428

Modificaciones estatutarias — 24/02/2012

Modificaciones estatutarias. Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/12. Datos registrales. T 623 , F 28, S 8, H L 11663, I/A 17 ( 9.02.12).

24/02/2012 Sec. I Nombramientos Lleida
Lleida-91429

Nombramientos — 24/02/2012

Nombramientos. Apoderado: JAÑEZ BARCENAS MARIA DEL CARMEN;PATO-CASTEL TADEO MARIA ELENA;SANJUAN MATONS LOURDES;GORGUES CARNICE DAVID;JAÑEZ BARCENAS MARIA DEL CARMEN;COLLADO RODRIGUEZ JESUS;PATO-CASTEL TADEO MARIA ELENA....

24/06/2011 Sec. I Ceses/Dimisiones Lleida
Lleida-268699

Ceses/dimisiones — 24/06/2011

Ceses/Dimisiones. Consejero: CORPFIN CAPITAL CONSEJEROS I SL;CORPFIN CAPITAL CONSEJEROS II SL;CORPFIN CAPITAL CONSEJEROS III SL. Nombramientos. Consejero: MCGOVERN HENRY JOSEPH;RANDALL CHANDLER MARK;BOLINSKI PIOTR. M.Co...