Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2018 20 tarjetas
11/10/2018 Sec. I Disolución Madrid
Madrid-410061

Disolución — 11/10/2018

Disolución. Fusion. Extinción. Datos registrales. T 36961 , F 21, S 8, H M 456870, I/A 12 ( 4.10.18).

26/06/2018 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-267172

Revocaciones — 26/06/2018

Revocaciones. Apoderado: BOLINSKI PIOTR;BOLINSKI PIOTR. Nombramientos. Apoderado: PIECHNA KRZYSZTOF. Datos registrales. T 36961 , F 16, S 8, H M 456870, I/A 11 (15.06.18).

23/05/2018 Sec. I Cambio de domicilio social Madrid
Madrid-217877

Cambio de domicilio social — 23/05/2018

Cambio de domicilio social. C/ ENRIQUE GRANADOS 6 - EDIFICIO B. NIVEL 2. OFICI (POZUELO DE ALARCON). Datos registrales. T 36961 , F 15, S 8, H M 456870, I/A 9 (10.05.18).

23/05/2018 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-217878

Nombramientos — 23/05/2018

Nombramientos. Apoderado: PRIEGO LUQUE MARIA DOLORES;SIMON MONTELONGO JOSE MANUEL. Datos registrales. T 36961 , F 16, S 8, H M 456870, I/A 10 (10.05.18).

15/01/2018 Sec. I Cambio de domicilio social Madrid
Madrid-19307

Cambio de domicilio social — 15/01/2018

Cambio de domicilio social. C/ ENRIQUE GRANADOS 6 - EDIFICIO B. NIVEL 1. OFICI (POZUELO DE ALARCON). Datos registrales. T 36961 , F 15, S 8, H M 456870, I/A 8 ( 8.01.18).

04/10/2017 Sec. I Reelecciones Lleida
Lleida-392414

Reelecciones — 04/10/2017

Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 1176 , F 48, S 8, H L 23108, I/A 25 (26.09.17).

10/05/2017 Sec. I Revocaciones Lleida
Lleida-196378

Revocaciones — 10/05/2017

Revocaciones. Apoderado: ESCORIAL SENANTE IÑIGO. Nombramientos. Apoderado: ROSADO ALCANTARA FRANCISCO. Datos registrales. T 1174 , F 225, S 8, H L 23108, I/A 24 ( 3.05.17).

15/03/2017 Sec. I Nombramientos Lleida
Lleida-119364

Nombramientos — 15/03/2017

Nombramientos. Apo.Manc.: JAÑEZ BARCENAS MARIA DEL CARMEN;MONEDERO MATEO ALBERTO. Datos registrales. T 1174 , F 225, S 8, H L 23108, I/A 23 ( 7.03.17).

03/03/2016 Sec. I Nombramientos Lleida
Lleida-100694

Nombramientos — 03/03/2016

Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ-PICAZO RODRIGUEZ MARIA. Datos registrales. T 1166 , F 181, S 8, H L 23108, I/A 20 (24.02.16).

11/11/2015 Sec. I Nombramientos Lleida
Lleida-453534

Nombramientos — 11/11/2015

Nombramientos. Apo.Manc.: GORGUES CARNICE DAVID;PATO-CASTEL TADEO MARIA ELENA;COLLADO RODRIGUEZ JESUS;JAÑEZ BARCENAS MARIA DEL CARMEN;BOLINSKI PIOTR;ROIGE TAMARIT JOSE;CAMPA PARRAMON GLORIA;CONTRERAS JAIMES GLADYS MARIA...

25/05/2015 Sec. I Ceses/Dimisiones Lleida
Lleida-210659

Ceses/dimisiones — 25/05/2015

Ceses/Dimisiones. Presidente: KENT WINEGAR STEVEN. Consejero: KENT WINEGAR STEVEN;MCGOVERN HENRY JOSEPH. Nombramientos. Consejero: COLLADO RODRIGUEZ JESUS. Presidente: BOLINSKI PIOTR. Otros conceptos: Fijación en tres d...

03/09/2014 Sec. I Reelecciones Lleida
Lleida-354064

Reelecciones — 03/09/2014

Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 1166 , F 173, S 8, H L 23108, I/A 17 (27.08.14).

16/06/2014 Sec. I Ampliación de capital Lleida
Lleida-250671

Ampliación de capital — 16/06/2014

Ampliación de capital. Capital: 120.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 123.006,00 Euros. Datos registrales. T 1166 , F 172, S 8, H L 23108, I/A 16 ( 9.06.14).

27/08/2013 Sec. I Ceses/Dimisiones Lleida
Lleida-377624

Ceses/dimisiones — 27/08/2013

Ceses/Dimisiones. Consejero: DE LA PEDRAJA ANGULO ENRIQUE. M.Com.Ej: KENT WINEGAR STEVEN;RANDALL CHANDLER MARK;BOLINSKI PIOTR. Otros conceptos: Refunden los Estatutos Sociales de la compañía. Datos registrales. T 1162 ,...

24/07/2013 Sec. I Ceses/Dimisiones Lleida
Lleida-332208

Ceses/dimisiones — 24/07/2013

Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: SANCHEZ MONTALBAN JOSE. Nombramientos. VsecrNoConsj: BOCOS MARTIN MARIA TERESA. Datos registrales. T 1162 , F 100, S 8, H L 23108, I/A 14 (17.07.13).

24/02/2012 Sec. I Modificaciones estatutarias Lleida
Lleida-91438

Modificaciones estatutarias — 24/02/2012

Modificaciones estatutarias. Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/12. Datos registrales. T 1162 , F 98, S 8, H L 23108, I/A 12 (10.02.12). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 39 Viernes 24 de febrero de 2012 Pág. 99...

24/02/2012 Sec. I Nombramientos Lleida
Lleida-91439

Nombramientos — 24/02/2012

Nombramientos. Apoderado: JAÑEZ BARCENAS MARIA DEL CARMEN;PATO-CASTEL TADEO MARIA ELENA;SANJUAN MATONS LOURDES;GORGUES CARNICE DAVID;JAÑEZ BARCENAS MARIA DEL CARMEN;COLLADO RODRIGUEZ JESUS;PATO-CASTEL TADEO MARIA ELENA....

24/01/2012 Sec. I Revocaciones Lleida
Lleida-32761

Revocaciones — 24/01/2012

Revocaciones. Auditor: DELOITTE SL. Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 1162 , F 97, S 8, H L 23108, I/A 11 (13.01.12).

24/06/2011 Sec. I Ceses/Dimisiones Lleida
Lleida-268713

Ceses/dimisiones — 24/06/2011

Ceses/Dimisiones. Consejero: CORPFIN CAPITAL CONSEJEROS III SL;CORPFIN CAPITAL CONSEJEROS I SL;CORPFIN CAPITAL CONSEJEROS II SL. Revocaciones. Apoderado: LAVILLA RUBIRA CARLOS. Nombramientos. Consejero: MCGOVERN HENRY J...

19/01/2011 Sec. I Nombramientos Lleida
Lleida-20193

Nombramientos — 19/01/2011

Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 1162 , F 96, S 8, H L 23108, I/A 9 ( 7.01.11).