Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2018 4 tarjetas
12/02/2018 Sec. I Cambio de denominación social Madrid
Madrid-68026

Cambio de denominación social — 12/02/2018

Cambio de denominación social. PULPOMATIC SL. Datos registrales. T 35666 , F 198, S 8, H M 609728, I/A 13 ( 2.02.18).

12/05/2016 Sec. I Cambio de domicilio social Madrid
Madrid-205324

Cambio de domicilio social — 12/05/2016

Cambio de domicilio social. C/ MONTE ESQUINZA, 30, BAJO IZQUIERDA (MADRID). Datos registrales. T 33881 , F 62, S 8, H M 609728, I/A 6 ( 4.05.16).

11/05/2016 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-203321

Nombramientos — 11/05/2016

Nombramientos. Apoderado: GOMEZ FRUCTUOSO FRANCISCO;GALLEANI DESIREE MACARENA. Datos registrales. T 33881 , F 61, S 8, H M 609728, I/A 5 ( 3.05.16).

11/03/2016 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-115966

Ceses/dimisiones — 11/03/2016

Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: BABE AYUSO EVARISTO. Nombramientos. Representan: BABE AYUSO EVARISTO. Consejero: STAY HUNGRY SL. Presidente: STAY HUNGRY SL. Consejero: ATALA SUCAR VICTOR MANUEL. Cons.Del.Sol: ATALA SUCAR...