Actos destacados
Nombramientos — 28/08/2019
Nombramientos. Auditor: OPINIA AUDITORES SLP. Modificaciones estatutarias. Se modifica el art. 19 de los estatutos sociales relaivo a la forma de convocatoria de la junta general.-. Datos registrales. T 1205 , F 110, S...
Revocaciones — 25/07/2019
Revocaciones. Apoderado: MAGALLANES FERNANDEZ CAYETANO. Datos registrales. T 1205 , F 109, S 8, H S 33342, I/A 5 (18.07.19).
Nombramientos — 12/07/2019
Nombramientos. Apo.Man.Soli: SAN MARTIN ARCE FRANCISCO;RAMON VILA JORGE;ARRIOLA MURRIETA JOSE MANUEL. Datos registrales. T 1205 , F 108, S 8, H S 33342, I/A 4 ( 4.07.19).
Cambio de domicilio social — 25/04/2019
Cambio de domicilio social. POLIG IND. DE CANDINA, C/ RIO PISUEÑA, S/N. (SANTANDER). Datos registrales. T 1205 , F 77, S 8, H S 33342, I/A 1 (15.04.19).
Ceses/dimisiones — 25/04/2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTINEZ VILLAGRA CARLOS;MARTINEZ VILLAGRA MARIA ISABEL;MARTINEZ VILLAGRA FERNANDO. Cons.Del.Sol: MARTINEZ VILLAGRA FERNANDO. Secretario: MARTINEZ VILLAGRA FERNANDO. Cons.Del.Sol: MARTINEZ V...
Revocaciones — 25/04/2019
Revocaciones. Apoderado: ROMAN MEDIAVILLA RAQUEL CARLOTA. Datos registrales. T 1205 , F 108, S 8, H S 33342, I/A 3 (15.04.19).
Reducción de capital — 05/12/2018
Reducción de capital. Importe reducción: 2.329.285,60 Euros. Resultante Suscrito: 68.508,40 Euros. Ampliación de capital. Suscrito: 2.400.000,00 Euros. Desembolsado: 2.400.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.468.508,40...
Reelecciones — 14/02/2018
Reelecciones. Auditor: KRESTON IBERAUDIT CYL SLP. Datos registrales. T 449 , F 68, S 8, H P 3232, I/A 50 ( 5.02.18).
Nombramientos — 29/05/2017
Nombramientos. Apoderado: ROMAN MEDIAVILLA RAQUEL CARLOTA. Datos registrales. T 449 , F 68, S 8, H P 3232, I/A 49 (19.05.17).
Revocaciones — 26/04/2017
Revocaciones. Apoderado: MIGUEL ANGEL FLANDES GALLO;MIGUEL ANGEL FLANDES GALLO. Apo.Man.Soli: ROMAN MEDIAVILLA RAQUEL CARLOTA;HERNANDEZ COS MIRIAM ELVIRA. Apo.Sol.: ROMAN MEDIAVILLA RAQUEL CARLOTA. Nombramientos. Apoder...
Ceses/dimisiones — 12/04/2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA SAAVEDRA ABOGADOS SL;PADARNO UNO SL;AESIR GESTORA DE INVERSIONES SLU. Presidente: GARCIA SAAVEDRA ABOGADOS SL. SecreNoConsj: DE LA IGLESIA PRIETO IRUNE. Nombramientos. Consejero: MART...
Nombramientos — 12/04/2017
Nombramientos. Presidente: MARTINEZ VILLAGRA CARLOS. Secretario: MARTINEZ VILLAGRA FERNANDO. Cons.Del.Sol: MARTINEZ VILLAGRA CARLOS;MARTINEZ VILLAGRA FERNANDO. Datos registrales. T 449 , F 67, S 8, H P 3232, I/A 47 ( 5....
Ceses/dimisiones — 05/04/2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: INMOBILIARIA SUSAETA LANZAROTE SL. Datos registrales. T 449 , F 66, S 8, H P 3232, I/A 45 (29.03.17).
Reelecciones — 02/11/2016
Reelecciones. Auditor: IBERAUDIT KRESTON CYL SLP. Datos registrales. T 449 , F 66, S 8, H P 3232, I/A 43 (19.10.16).
Reelecciones — 02/11/2016
Reelecciones. Auditor: IBERAUDIT KRESTON CYL SLP. Datos registrales. T 449 , F 66, S 8, H P 3232, I/A 44 (19.10.16).
Ceses/dimisiones — 17/03/2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: ADE CAPITAL SODICAL SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO DE. Datos registrales. T 449 , F 66, S 8, H P 3232, I/A 42 ( 8.03.16). http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL D.L.: M-5188/19...
Reelecciones — 13/10/2015
Reelecciones. Consejero: GARCIA SAAVEDRA ABOGADOS SL;PADARNO UNO SL;ADE CAPITAL SODICAL SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO DE;AESIR GESTORA DE INVERSIONES SLU;INMOBILIARIA SUSAETA LANZAROTE SL.Auditor: IBERAUDIT KRESTON CYL SLP...
Ceses/dimisiones — 13/10/2015
Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: AESIR GESTORA DE INVERSIONES SLU. Reelecciones. SecreNoConsj: DE LA IGLESIA PRIETO IRUNE. Presidente: GARCIA SAAVEDRA ABOGADOS SL. Datos registrales. T 449 , F 66, S 8, H P 3232, I/A 41 (...
Reducción de capital — 27/05/2015
Reducción de capital. Importe reducción: 274.792,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.397.794,00 Euros. Datos registrales. T 449 , F 65, S 8, H P 3232, I/A 39 (20.05.15).
Modificaciones estatutarias — 08/04/2015
Modificaciones estatutarias. 19. Funcionamiento Junta Gral.-. Datos registrales. T 449 , F 63, S 8, H P 3232, I/A 37 (27.03.15).
Revocaciones — 08/04/2015
Revocaciones. Apoderado: VELASCO CELADA FRANCISCO. Nombramientos. Apo.Sol.: ROMAN MEDIAVILLA RAQUEL CARLOTA. Datos registrales. T 449 , F 64, S 8, H P 3232, I/A 38 (27.03.15).
Reelecciones — 12/12/2014
Reelecciones. Auditor: LOMAS AUDITORES SL PROFESIONAL. Datos registrales. T 449 , F 63, S 8, H P 3232, I/A 36 ( 4.12.14).
Revocaciones — 15/07/2014
Revocaciones. Apo.Sol.: HERNANDEZ COS MIRIAM ELVIRA;ROMAN MEDIAVILLA RAQUEL CARLOTA. Nombramientos. Apo.Man.Soli: HERNANDEZ COS MIRIAM ELVIRA;ROMAN MEDIAVILLA RAQUEL CARLOTA. Datos registrales. T 449 , F 62, S 8, H P 32...
Ceses/dimisiones — 25/09/2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: ADCOPA UNO S L. Presidente: ADCOPA UNO S L. Nombramientos. Consejero: GARCIA SAAVEDRA ABOGADOS SL. Presidente: GARCIA SAAVEDRA ABOGADOS SL. Reelecciones. Auditor: LOMAS AUDITORES SL PROFESIO...