Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2019 11 tarjetas
09/08/2019 Sec. I Otros conceptos: Modificacion de los estatutos sociales en su integridad Murcia
Murcia-350697

Otros conceptos: modificacion de los estatutos sociales en su integridad — 09/08/2019

Otros conceptos: Modificacion de los estatutos sociales en su integridad. Cambio de denominación social. FLORETTE MURCIA SL. Cambio de objeto social. a) La actividad de producir frutas y hortalizas frescas, destinadas a...

08/04/2019 Sec. I Declaración de unipersonalidad Murcia
Murcia-156975

Declaración de unipersonalidad — 08/04/2019

Declaración de unipersonalidad. Socio único: FLORETTE IBERICA S.L. Datos registrales. T 3103 , F 80, S 8, H MU 86670, I/A 8 ( 1.04.19).

07/05/2018 Sec. I Revocaciones Murcia
Murcia-194170

Revocaciones — 07/05/2018

Revocaciones. Apo.Manc.: SONIA BAIGORRI SAEZ. Datos registrales. T 3103 , F 80, S 8, H MU 86670, I/A 7 (27.04.18).

12/04/2018 Sec. I Reelecciones Murcia
Murcia-162869

Reelecciones — 12/04/2018

Reelecciones. Consejero: JESUS JAVIER CIA BARRIO. Secretario: JESUS JAVIER CIA BARRIO. Datos registrales. T 3103 , F 80, S 8, H MU 86670, I/A 6 ( 6.04.18).

12/04/2017 Sec. I Ceses/Dimisiones Murcia
Murcia-163810

Ceses/dimisiones — 12/04/2017

Ceses/Dimisiones. Consejero: MANUEL GIL DEL ARCO. Presidente: MANUEL GIL DEL ARCO. Nombramientos. Consejero: PEDRO FERNANDEZ PANIZO. Presidente: PEDRO FERNANDEZ PANIZO. Datos registrales. T 3103 , F 80, S 8, H MU 86670,...

06/07/2015 Sec. I Revocaciones Murcia
Murcia-275834

Revocaciones — 06/07/2015

Revocaciones. Apoderado: MARIA DEL PUY MONLEON MURO. Datos registrales. T 3103 , F 80, S 8, H MU 86670, I/A 4 (29.06.15).

26/05/2015 Sec. I Reelecciones Murcia
Murcia-213364

Reelecciones — 26/05/2015

Reelecciones. Consejero: MANUEL GIL DEL ARCO. Presidente: MANUEL GIL DEL ARCO. Datos registrales. T 3056 , F 108, S 8, H MU 86670, I/A 3 (19.05.15). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 97 Martes 26 de mayo de 20...

14/02/2014 Sec. I Revocaciones Córdoba
Córdoba-69251

Revocaciones — 14/02/2014

Revocaciones. Apoderado: MORENO VIRTO JORGE. Apo.Sol.: FLORISTAN FLORISTAN JUAN MIGUEL. Nombramientos. Apoderado: MORENO VIRTO JORGE. Datos registrales. T 2016 , F 144, S 8, H CO 26408, I/A 13 ( 7.02.14).

21/12/2012 Sec. I Reelecciones Córdoba
Córdoba-531972

Reelecciones — 21/12/2012

Reelecciones. Consejero: CIA BARRIO JESUS JAVIER. Secretario: CIA BARRIO JESUS JAVIER. Datos registrales. T 2014 , F 225, S 8, H CO 26408, I/A 12 (14.12.12).

05/05/2011 Sec. I Revocaciones Córdoba
Córdoba-193408

Revocaciones — 05/05/2011

Revocaciones. Apoderado: IBAÑEZ GANUZA ANGEL;FERNANDEZ PANIZO PEDRO. Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ PANIZO PEDRO. Datos registrales. T 2014 , F 223, S 8, H CO 26408, I/A 11 (25.04.11). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO...

16/12/2010 Sec. I Ceses/Dimisiones Córdoba
Córdoba-463431

Ceses/dimisiones — 16/12/2010

Ceses/Dimisiones. Consejero: FLORISTAN FLORISTAN JUAN MIGUEL. Presidente: FLORISTAN FLORISTAN JUAN MIGUEL. Consejero: TORIBIO FERNANDEZ ANTONIO. Nombramientos. Consejero: GIL ARCO MANUEL;LOZANO BOLIVAR JOSE. Presidente:...