Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2015 6 tarjetas
16/03/2015 Sec. I Ceses/Dimisiones Gipuzkoa
Gipuzkoa-111655

Ceses/dimisiones — 16/03/2015

Ceses/Dimisiones. Consejero: PISABARRO PISABARRO ELEUTERIO;LOPEZ SANCHEZ JUAN PEDRO;OLONDRIS IBAÑEZ MANUEL PEDRO;SANCHEZ ORRUÑO FRANCISCO JAVIER;GOICOECHEA AMONARRAIZ LUIS MARIA;LEGARREA MENDILUCE JORGE-JUAN. Presidente...

16/04/2013 Sec. I Ampliación de capital Gipuzkoa
Gipuzkoa-177510

Ampliación de capital — 16/04/2013

Ampliación de capital. Suscrito: 81.128,99 Euros. Desembolsado: 81.128,99 Euros. Resultante Suscrito: 799.323,99 Euros. Resultante Desembolsado: 799.323,99 Euros. Datos registrales. T 1318 , F 64, S 8, H SS 6136, I/A 17...

19/07/2012 Sec. I Ceses/Dimisiones Gipuzkoa
Gipuzkoa-304737

Ceses/dimisiones — 19/07/2012

Ceses/Dimisiones. Consejero: DEL SOL MERINO MANUEL. Reelecciones. Consejero: PISABARRO PISABARRO ELEUTERIO;LEGARREA MENDILUCE JORGE-JUAN;GOICOECHEA AMONARRAIZ LUIS MARIA;SANCHEZ ORRUÑO FRANCISCO JAVIER;OLONDRIS IBAÑEZ M...

18/05/2011 Sec. I Ceses/Dimisiones Gipuzkoa
Gipuzkoa-211832

Ceses/dimisiones — 18/05/2011

Ceses/Dimisiones. Secretario: GOICOECHEA BENZALA JUAN-LUIS. Nombramientos. Secretario: LEGARREA MENDILUCE JORGE-JUAN. Datos registrales. T 1318 , F 62, S 8, H SS 6136, I/A 13 (10.05.11).

18/05/2011 Sec. I Revocaciones Gipuzkoa
Gipuzkoa-211833

Revocaciones — 18/05/2011

Revocaciones. Apo.Manc.: PISABARRO PISABARRO ELEUTERIO;GOICOECHEA BENZALA JUAN-LUIS. Datos registrales. T 1318 , F 63, S 8, H SS 6136, I/A 14 (10.05.11).

18/05/2011 Sec. I Nombramientos Gipuzkoa
Gipuzkoa-211834

Nombramientos — 18/05/2011

Nombramientos. Apo.Manc.: PISABARRO PISABARRO ELEUTERIO;LEGARREA MENDILUCE JORGE-JUAN. Datos registrales. T 1318 , F 63, S 8, H SS 6136, I/A 15 (10.05.11). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 94 Miércoles 18 de...