Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2016 23 tarjetas
19/08/2016 Sec. I Cambio de denominación social Cantabria
Cantabria-342025

Cambio de denominación social — 19/08/2016

Cambio de denominación social. OXITAL SERVICIOS, S.L. Datos registrales. T 1112 , F 209, S 8, H S 734, I/A 41 (10.08.16).

02/02/2016 Sec. I Reelecciones Cantabria
Cantabria-44133

Reelecciones — 02/02/2016

Reelecciones. Auditor: ABOLL AUDITORES S L P. Datos registrales. T 1112 , F 209, S 8, H S 734, I/A 40 (21.01.16).

22/10/2015 Sec. I Escisión parcial Cantabria
Cantabria-423928

Escisión parcial — 22/10/2015

Escisión parcial. Sociedades beneficiarias de la escisión: OXITAL AGUAS, SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 1043 , F 53, S 8, H S 734, I/A 39 (14.10.15).

29/05/2015 Sec. I Reelecciones Cantabria
Cantabria-218957

Reelecciones — 29/05/2015

Reelecciones. Auditor: ABOLL AUDITORES S L P. Datos registrales. T 1043 , F 53, S 8, H S 734, I/A 38 (21.05.15).

25/09/2014 Sec. I Reelecciones Cantabria
Cantabria-381841

Reelecciones — 25/09/2014

Reelecciones. Auditor: ABOLL AUDITORES S L P. Datos registrales. T 1043 , F 52, S 8, H S 734, I/A 35 (19.09.14). http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958

08/10/2013 Sec. I Nombramientos Cantabria
Cantabria-429855

Nombramientos — 08/10/2013

Nombramientos. Apo.Sol.: SUAREZ MAZA ANA. Datos registrales. T 1043 , F 52, S 8, H S 734, I/A 34 (30.09.13). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 192 Martes 8 de octubre de 2013 Pág. 46522 cve: BORME-A-2013-192-39

30/07/2013 Sec. I Nombramientos Cantabria
Cantabria-340576

Nombramientos — 30/07/2013

Nombramientos. Apo.Sol.: RODRIGUEZ FERRERAS MIGUEL. Datos registrales. T 1043 , F 51, S 8, H S 734, I/A 32 (20.07.13).

30/07/2013 Sec. I Nombramientos Cantabria
Cantabria-340577

Nombramientos — 30/07/2013

Nombramientos. Apo.Sol.: RODRIGUEZ FERRERAS MIGUEL. Datos registrales. T 1043 , F 51, S 8, H S 734, I/A 33 (20.07.13).

26/07/2013 Sec. I Nombramientos Cantabria
Cantabria-335637

Nombramientos — 26/07/2013

Nombramientos. Apo.Sol.: RODRIGUEZ FERRERAS MIGUEL. Datos registrales. T 970 , F 136, S 8, H S 734, I/A 26 (17.07.13).

26/07/2013 Sec. I Nombramientos Cantabria
Cantabria-335638

Nombramientos — 26/07/2013

Nombramientos. Apo.Sol.: RODRIGUEZ FERRERAS MIGUEL. Datos registrales. T 970 , F 137, S 8, H S 734, I/A 27 (17.07.13).

26/07/2013 Sec. I Nombramientos Cantabria
Cantabria-335639

Nombramientos — 26/07/2013

Nombramientos. Apo.Sol.: RODRIGUEZ FERRERAS MIGUEL. Datos registrales. T 970 , F 137, S 8, H S 734, I/A 28 (17.07.13).

26/07/2013 Sec. I Nombramientos Cantabria
Cantabria-335640

Nombramientos — 26/07/2013

Nombramientos. Apo.Sol.: RODRIGUEZ FERRERAS MIGUEL;FERNANDEZ PELLICER PILAR;SATURNINO DIAZ MATEOS;GOMEZ GONZALEZ JAVIER;ARRIOLA PEREDA FRANCISCO. Datos registrales. T 1043 , F 49, S 8, H S 734, I/A 29 (17.07.13). BOLETÍ...

26/07/2013 Sec. I Nombramientos Cantabria
Cantabria-335641

Nombramientos — 26/07/2013

Nombramientos. Apo.Manc.: RODRIGUEZ FERRERAS MIGUEL;FERNANDEZ PELLICER PILAR;DEL RIO GONZALEZ JAIME;GOMEZ GONZALEZ JAVIER;TORRE BALSEIRO JESUS;ARRIOLA PEREDA FRANCISCO;MARTINEZ GOMEZ ADELA. Datos registrales. T 1043 , F...

26/07/2013 Sec. I Ceses/Dimisiones Cantabria
Cantabria-335642

Ceses/dimisiones — 26/07/2013

Ceses/Dimisiones. Consejero: MANDALUNIZ LANDALUCE FRANCISCO JAVIER;LA PLAZOLETA EXPORTS S.L. Cons.Del.Sol: LA PLAZOLETA EXPORTS S.L. Consejero: CENTRO DE NEGOCIOS Y ACTIVIDADES ECONOMICAS S.L. Presidente: LA PLAZOLETA E...

08/01/2013 Sec. I Nombramientos Cantabria
Cantabria-6686

Nombramientos — 08/01/2013

Nombramientos. Consejero: ARAVEDES SL. Datos registrales. T 970 , F 136, S 8, H S 734, I/A 25 (27.12.12).

20/08/2012 Sec. I Ceses/Dimisiones Cantabria
Cantabria-346606

Ceses/dimisiones — 20/08/2012

Ceses/Dimisiones. Consejero: HUERTA CASTILLO MANUEL. Presidente: HUERTA CASTILLO MANUEL. Vicepresid.: LA PLAZOLETA EXPORTS S.L. Nombramientos. Consejero: CENTRO DE NEGOCIOS Y ACTIVIDADES ECONOMICAS S.L. Presidente: LA P...

18/04/2011 Sec. I Nombramientos Cantabria
Cantabria-172226

Nombramientos — 18/04/2011

Nombramientos. Apoderado: ECHEVARRIA ARECHALDE EMILIANO. Datos registrales. T 970 , F 135, S 8, H S 734, I/A 22 ( 5.04.11).

18/02/2011 Sec. I Reelecciones Cantabria
Cantabria-74613

Reelecciones — 18/02/2011

Reelecciones. Auditor: ABOLL AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 970 , F 135, S 8, H S 734, I/A 21 ( 8.02.11).

20/01/2011 Sec. I Nombramientos Cantabria
Cantabria-21626

Nombramientos — 20/01/2011

Nombramientos. Apoderado: ECHEVARRIA ARECHALDE EMILIANO. Datos registrales. T 970 , F 134, S 8, H S 734, I/A 20 (10.01.11).

28/12/2010 Sec. I Ceses/Dimisiones Cantabria
Cantabria-481231

Ceses/dimisiones — 28/12/2010

Ceses/Dimisiones. Secretario: MANDALUNIZ LANDALUCE FRANCISCO JAVIER. Co.De.Ma.So: MANDALUNIZ LANDALUCE FRANCISCO JAVIER;HUERTA TERAN MANUEL. Nombramientos. Con.Delegado: HUERTA TERAN MANUEL. SecreNoConsj: TOMAS DIEZ SAN...

27/10/2009 Sec. I Modificaciones estatutarias Cantabria
Cantabria-448669

Modificaciones estatutarias — 27/10/2009

Modificaciones estatutarias. Modificado el artículo 29 de los estatutos sociales en cuanto a la remuneración de los administradores.. Datos registrales. T 970 , F 133, S 8, H S 734, I/A 18 (14.10.09).

16/06/2009 Sec. I Ceses/Dimisiones Cantabria
Cantabria-270456

Ceses/dimisiones — 16/06/2009

Ceses/Dimisiones. Consejero: HUERTA TERAN ALICIA. Presidente: HUERTA TERAN ALICIA. Consejero: HUERTA TERAN MANUEL. Vicepresid.: HUERTA TERAN MANUEL. Consejero: MANDALUNIZ LANDALUCE FRANCISCO JAVIER. Secretario: MANDALUN...

26/01/2009 Sec. I Reducción de capital Cantabria
Cantabria-41212

Reducción de capital — 26/01/2009

Reducción de capital. Importe reducción: 21.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 315.000,00 Euros. Datos registrales. T 654 , F 11, S 8, H S 734, I/A 16 (15.01.09).