Actos destacados
Nombramientos — 16/12/2019
Nombramientos. Apoderado: LIÑEIRA MOSQUERA SANDRA. Datos registrales. T 414 , F 162, S 8, H LU 627, I/A 72 ( 4.12.19).
Cancelaciones de oficio de nombramientos — 21/11/2019
Cancelaciones de oficio de nombramientos. Auditor: AUDITGAL SA;KPMG AUDITORES SL. Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 414 , F 162, S 8, H LU 627, I/A 71 ( 6.11.19).
Reelecciones — 27/02/2019
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 414 , F 162, S 8, H LU 627, I/A 70 (14.02.19).
Nombramientos — 13/02/2019
Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ BURRIEL SUSANA. Datos registrales. T 414 , F 161, S 8, H LU 627, I/A 68 (28.01.19).
Nombramientos — 13/02/2019
Nombramientos. Apo.Sol.: LOPEZ OLIAS ROBERTO;FERNANDEZ CASAS RAFAEL EDUARDO;SAN MARTIN FERREIRO JUAN. Datos registrales. T 414 , F 161, S 8, H LU 627, I/A 69 (28.01.19).
Nombramientos — 07/02/2018
Nombramientos. Apoderado: SAN MARTIN FERREIRO JUAN. Datos registrales. T 414 , F 160, S 8, H LU 627, I/A 67 (16.01.18).
Reelecciones — 24/01/2018
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 414 , F 160, S 8, H LU 627, I/A 66 ( 9.01.18).
Revocaciones — 24/08/2017
Revocaciones. Apoderado: FERNANDEZ DE LA MESA DIAZ DEL RIO JOSE RAMON. Datos registrales. T 414 , F 159, S 8, H LU 627, I/A 65 (11.08.17).
Nombramientos — 10/11/2016
Nombramientos. Apoderado: LOPEZ OLIAS ROBERTO. Datos registrales. T 414 , F 159, S 8, H LU 627, I/A 64 (27.10.16).
Revocaciones — 20/11/2015
Revocaciones. Apoderado: AMAGO VERDUGO CARMEN. Datos registrales. T 414 , F 159, S 8, H LU 627, I/A 63 (12.11.15).
Reelecciones — 16/11/2015
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 414 , F 158, S 8, H LU 627, I/A 62 ( 5.11.15).
Revocaciones — 06/08/2015
Revocaciones. Apo.Manc.: VILANOVA VILA JOSE LUIS. Datos registrales. T 414 , F 158, S 8, H LU 627, I/A 60 B (14.03.14).
Nombramientos — 09/03/2015
Nombramientos. Apoderado: CILLERUELO TROTTER JOSE ANGEL. Datos registrales. T 414 , F 158, S 8, H LU 627, I/A 61 (26.02.15).
Revocaciones — 24/03/2014
Revocaciones. Apoderado: VILANOVA VILA JOSE LUIS. Datos registrales. T 414 , F 158, S 8, H LU 627, I/A 60 (14.03.14).
Reelecciones — 30/10/2013
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 414 , F 158, S 8, H LU 627, I/A 59 (22.10.13).
Revocaciones — 05/07/2013
Revocaciones. Apoderado: RODRIGUEZ GARCIA RODOLFO. Datos registrales. T 414 , F 158, S 8, H LU 627, I/A 58 (27.06.13).
Revocaciones — 26/04/2013
Revocaciones. Apoderado: BLANCO MARTIN DIONISIO. Datos registrales. T 414 , F 158, S 8, H LU 627, I/A 57 (19.04.13).
Revocaciones — 14/02/2012
Revocaciones. Apoderado: HERVE GABRIEL EDMOND GRILLOT;MARTINEZ AYESTARAN JOSE MARIA;GOLES BARRIENTOS YERKO ALEJANDRO. Datos registrales. T 414 , F 158, S 8, H LU 627, I/A 56 ( 2.02.12).
Nombramientos — 26/07/2011
Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ MONGE ISABEL. Datos registrales. T 414 , F 157, S 8, H LU 627, I/A 54 ( 9.07.11).
Nombramientos — 26/07/2011
Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ MONGE ISABEL. Datos registrales. T 414 , F 157, S 8, H LU 627, I/A 55 ( 9.07.11).
Reelecciones — 15/12/2010
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 414 , F 157, S 8, H LU 627, I/A 53 (29.11.10).
Declaración de unipersonalidad — 11/03/2010
Declaración de unipersonalidad. Socio único: PROBISA TECNOLOGIA Y CONSTRUCCION SA. Datos registrales. T 414 , F 157, S 8, H LU 627, I/A 51 (26.02.10).