Actos destacados
Nombramientos — 11/10/2012
Nombramientos. Apoderado: AGUILA LLORENS FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 2484 , F 152, S 8, H PM 62579, I/A 15 ( 2.10.12).
Revocaciones — 22/08/2012
Revocaciones. Apo.Sol.: PONCE GUTIERREZ IGNACIO. Datos registrales. T 2484 , F 151, S 8, H PM 62579, I/A 14 ( 9.08.12).
Nombramientos — 11/07/2012
Nombramientos. Apoderado: JANER GONZALEZ JOSE. Datos registrales. T 2484 , F 151, S 8, H PM 62579, I/A 13 ( 3.07.12).
Nombramientos — 23/02/2012
Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 2484 , F 151, S 8, H PM 62579, I/A 12 (10.02.12).
Ampliación de capital — 06/02/2012
Ampliación de capital. Capital: 1,00 Euros. Resultante Suscrito: 240.405,00 Euros. Datos registrales. T 2358 , F 111, S 8, H PM 62579, I/A 11 (26.01.12).
Nombramientos — 19/01/2012
Nombramientos. Apoderado: MARTIN-AMBROSIO MERINO ENRIQUE. Datos registrales. T 2358 , F 111, S 8, H PM 62579, I/A 10 (10.01.12). http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-99...
Modificaciones estatutarias — 08/11/2011
Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: Modificación artículo 25º de los estatutos a consecuencia de la modificación del ejercicio social, que en adelante comenzará el 01 de noviembre de cadaaño natural...
Revocaciones — 26/08/2011
Revocaciones. Apo.Sol.: VARGAS CINCA JOAN. Datos registrales. T 2358 , F 111, S 8, H PM 62579, I/A 8 (16.08.11).
Nombramientos — 11/04/2011
Nombramientos. Apoderado: VAZQUEZ LOSADA ALVARO. Datos registrales. T 2358 , F 110, S 8, H PM 62579, I/A 7 (30.03.11).
Revocaciones — 01/10/2010
Revocaciones. Apo.Sol.: SUBIAS CANO GABRIEL MARIA;ARELLANO GIL MIGUEL ANGEL. Apoderado: SUBIAS CANO ALEJANDRO MARIA. Nombramientos. Apo.Sol.: PONCE GUTIERREZ IGNACIO;DUATO BARCIA JOSE MANUEL. Datos registrales. T 2358 ,...