Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2019 14 tarjetas
05/03/2019 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-101952

Nombramientos — 05/03/2019

Nombramientos. Apo.Manc.: ENSEÑAT ROCA BORJA. Datos registrales. T 27577 , F 93, S 8, H M 333816, I/A 63 (26.02.19). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 44 Martes 5 de marzo de 2019 Pág. 10739 cve: BORME-A-2019-...

23/07/2018 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-304070

Revocaciones — 23/07/2018

Revocaciones. Apoderado: FUENTES MARTIN JORGE FRANCISCO. Apo.Manc.: FUENTES MARTIN JORGE FRANCISCO;FUENTES MARTIN JORGE FRANCISCO. Datos registrales. T 27577 , F 93, S 8, H M 333816, I/A 61 (13.07.18).

02/03/2018 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-101672

Nombramientos — 02/03/2018

Nombramientos. Apoderado: CORPA MARTINEZ ABRAHAM. Datos registrales. T 27577 , F 92, S 8, H M 333816, I/A 59 (21.02.18).

10/11/2017 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-441739

Nombramientos — 10/11/2017

Nombramientos. Apo.Sol.: ENSEÑAT ROCA BORJA. Apo.Manc.: ENSEÑAT ROCA BORJA;FUENTES MARTIN JORGE FRANCISCO;GARCIA MUÑOZ EMILIO. Datos registrales. T 27577 , F 91, S 8, H M 333816, I/A 57 ( 2.11.17).

14/11/2014 Sec. I Otros conceptos: SUBSANACION DE LA ESCR Madrid
Madrid-462207

Otros conceptos: subsanacion de la escr — 14/11/2014

Otros conceptos: SUBSANACION DE LA ESCR. AUTORIZADA POR EL NOTARIO DE MADRID, D& ISABEL ESTAPE TOUS, EL 17.09.2014, CON EL Nº 4.083 DE SU PROTOCOLO, QUE CAUSO LA INSCRIPCION 52& DE LA HOJA SOCIAL, EN LA QUE SE RESEÑO ER...

31/12/2013 Sec. I Reelecciones Madrid
Madrid-559343

Reelecciones — 31/12/2013

Reelecciones. Auditor: FEDATA AUDITORES SLP. Datos registrales. T 27577 , F 87, S 8, H M 333816, I/A 45 (23.12.13).

11/12/2012 Sec. I Modificaciones estatutarias Madrid
Madrid-512869

Modificaciones estatutarias — 11/12/2012

Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 2. Objeto.-. Ampliacion del objeto social. LA CONSTRUCCION, REPARACION, REHABILITACION, CONSOLIDACION, RESTAURACION, DECORACION, ORNAMENTACION, CONSERVACION Y MANT...

11/10/2012 Sec. I Modificaciones estatutarias Madrid
Madrid-416581

Modificaciones estatutarias — 11/10/2012

Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 4. Domicilio.-. Cambio de domicilio social. C/ ORENSE 81 4& (MADRID). Datos registrales. T 27577 , F 83, S 8, H M 333816, I/A 37 ( 2.10.12).

27/05/2010 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-212393

Nombramientos — 27/05/2010

Nombramientos. Apoderado: PEREIRA GARCIA DAVID. Datos registrales. T 19088 , F 142, S 8, H M 333816, I/A 29 (17.05.10). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 100 Jueves 27 de mayo de 2010 Pág. 26289 cve: BORME-A-2...

27/05/2010 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-212394

Nombramientos — 27/05/2010

Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ MARTI FRANCESC. Datos registrales. T 19088 , F 143, S 8, H M 333816, I/A 30 (17.05.10).

27/05/2010 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-212395

Nombramientos — 27/05/2010

Nombramientos. Apoderado: VIVO CAMPO JUAN IGNACIO. Datos registrales. T 19088 , F 143, S 8, H M 333816, I/A 31 (17.05.10).

21/04/2010 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-159264

Nombramientos — 21/04/2010

Nombramientos. Apoderado: GARCIA MUÑOZ EMILIO. Datos registrales. T 19088 , F 142, S 8, H M 333816, I/A 28 (12.04.10).

23/12/2009 Sec. I Fusión por absorción Madrid
Madrid-533789

Fusión por absorción — 23/12/2009

Fusión por absorción. Sociedades absorbidas: URBALUX GESTION Y PROMOCION SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 19088 , F 141, S 8, H M 333816, I/A 26 (11.12.09).

27/05/2009 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-241767

Nombramientos — 27/05/2009

Nombramientos. Apoderado: DEL LLANO VIVANCOS PEDRO JAVIER. Datos registrales. T 19088 , F 140, S 8, H M 333816, I/A 24 (14.05.09). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 98 Miércoles 27 de mayo de 2009 Pág. 28025 c...