Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2016 11 tarjetas
04/01/2016 Sec. I Ceses/Dimisiones Gipuzkoa
Gipuzkoa-921

Ceses/dimisiones — 04/01/2016

Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ONE FACILITY SERVICES SL. Disolución. Fusion. Extinción. Datos registrales. T 2719 , F 181, S 8, H SS 37948, I/A 3 (23.12.15).

11/11/2015 Sec. I Cambio de domicilio social Gipuzkoa
Gipuzkoa-453387

Cambio de domicilio social — 11/11/2015

Cambio de domicilio social. C/ TROIA, Nº 14-PABELLON 5-POLIGONO TXALAKA ARANED (ASTIGARRAGA). Datos registrales. T 2719 , F 137, S 8, H SS 37948, I/A 1 ( 2.11.15).

06/03/2014 Sec. I Otros conceptos: Designada Doña Alicia María Arrate Illarramendi Leturia como persona física representante del administrador único BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm Navarra
Navarra-104717

Otros conceptos: designada doña alicia maría arrate illarramendi leturia como persona física representante del administrador único boletÍn oficial del registro mercantil núm — 06/03/2014

Otros conceptos: Designada Doña Alicia María Arrate Illarramendi Leturia como persona física representante del administrador único BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 45 Jueves 6 de marzo de 2014 Pág. 11186 cve:...

19/11/2012 Sec. I Nombramientos Navarra
Navarra-472212

Nombramientos — 19/11/2012

Nombramientos. Apoderado: MUÑOZ GALARZA JOSEBA;MILIAN ESPADA ANA BELEN. Datos registrales. T 480 , F 40, S 8, H NA 8170, I/A 31 ( 6.11.12).

19/11/2012 Sec. I Nombramientos Navarra
Navarra-472213

Nombramientos — 19/11/2012

Nombramientos. Apoderado: GARATE IRAOLAGOITIA ALBERTO. Datos registrales. T 480 , F 40, S 8, H NA 8170, I/A 32 ( 6.11.12).

15/11/2012 Sec. I Revocaciones Navarra
Navarra-467571

Revocaciones — 15/11/2012

Revocaciones. Apoderado: ANDRES ASENSIO VICTOR MANUEL. Datos registrales. T 480 , F 40, S 8, H NA 8170, I/A 30 (31.10.12).

05/11/2012 Sec. I Nombramientos Navarra
Navarra-453323

Nombramientos — 05/11/2012

Nombramientos. Apoderado: SANZ PASCUAL CAROLINA;GALLEGO MARTIN YOSUNE. Datos registrales. T 480 , F 39, S 8, H NA 8170, I/A 29 (22.10.12).

21/03/2012 Sec. I Cambio de domicilio social Navarra
Navarra-132570

Cambio de domicilio social — 21/03/2012

Cambio de domicilio social. POLIG INDUSTRIAL MUTILVA BAJA, CALLE O, NAVE 3 (ARANGUREN). Datos registrales. T 480 , F 39, S 8, H NA 8170, I/A 28 ( 2.03.12).

23/12/2011 Sec. I Cambio de objeto social Navarra
Navarra-513419

Cambio de objeto social — 23/12/2011

Cambio de objeto social. a.- La limpieza de edificios y locales, incluidos exteriores, pisos, oficinas, portales, escaleras, almacenes, instalaciones de hostelería, teatros, cines, fábricas, clínicas, hospitales y cualq...

23/12/2011 Sec. I Nombramientos Navarra
Navarra-513420

Nombramientos — 23/12/2011

Nombramientos. Apoderado: GARDE PAZ EMILIO;ANDRES ASENSIO VICTOR MANUEL;OYARZABAL URQUIOLA JOSE IGNACIO. Datos registrales. T 480 , F 37, S 8, H NA 8170, I/A 27 (12.12.11).

24/05/2011 Sec. I Otros conceptos: El socio único y administrador único de la sociedad LIMPECOSL, la mercantil "SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL EVOHE,S Navarra
Navarra-221523

Otros conceptos: el socio único y administrador único de la sociedad limpecosl, la mercantil "servicio de mantenimiento integral evohe,s — 24/05/2011

Otros conceptos: El socio único y administrador único de la sociedad LIMPECOSL, la mercantil "SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL EVOHE,S. L." CAMBIO SU DENOMINACION por la de "ONE SERVICIOS INMUEBLES, S.L.", en virtud d...