Actos destacados
Disolución — 09/12/2016
Disolución. Fusion. Extinción. Datos registrales. T 3681 , F 153, S 8, H Z 35354, I/A F (29.11.16).
Otros conceptos: cerrada la hoja por plazo provisional de seis meses, conforme al articulo 231 del reglamento del registro mercantil — 07/10/2016
Otros conceptos: CERRADA LA HOJA POR PLAZO PROVISIONAL DE SEIS MESES, CONFORME AL ARTICULO 231 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO MERCANTIL. Datos registrales. T 3681 , F 153, S 8, H Z 35354, I/A 21 N (29.09.16).
Revocaciones — 11/11/2014
Revocaciones. Auditor: MAZARS AUDITORES SLP. Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 3681 , F 153, S 8, H Z 35354, I/A 21 (31.10.14).
Reelecciones — 12/03/2014
Reelecciones. Auditor: MAZARS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 3681 , F 152, S 8, H Z 35354, I/A 20 ( 3.03.14).
Reelecciones — 10/10/2013
Reelecciones. Adm. Solid.: BALLARIN BIBIAN JOSE;JORDAN LANASPA LUIS-ALBERTO;BALLARIN DOMEQUE MARIA JOSE. Datos registrales. T 3681 , F 152, S 8, H Z 35354, I/A 19 ( 2.10.13).
Revocaciones — 07/09/2012
Revocaciones. Apoderado: ALVAREZ HERRAIZ CARLOS. Datos registrales. T 3681 , F 152, S 8, H Z 35354, I/A 18 (27.08.12).
Nombramientos — 20/06/2012
Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ DE MORENTIN MORRAS JOSE IGNACIO. Datos registrales. T 3681 , F 152, S 8, H Z 35354, I/A 17 ( 8.06.12).
Revocaciones — 18/05/2012
Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ GUILLEN ALFREDO. Apo.Man.Soli: MARTINEZ GUILLEN ALFREDO;JUDEZ AGUADO PEDRO;HUGUET JUANENA JOSE MARIA. Datos registrales. T 3681 , F 152, S 8, H Z 35354, I/A 16 ( 7.05.12). BOLETÍN OFICI...
Nombramientos — 08/03/2012
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GOMEZ FERNANDEZ JAVIER;JUDEZ AGUADO PEDRO;HUGUET JUANENA JOSE MARIA. Datos registrales. T 3681 , F 150, S 8, H Z 35354, I/A 14 (28.02.12). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 48 Juev...
Nombramientos — 08/03/2012
Nombramientos. Apoderado: GOMEZ FERNANDEZ JAVIER. Datos registrales. T 3681 , F 151, S 8, H Z 35354, I/A 15 (28.02.12).
Revocaciones — 13/12/2011
Revocaciones. Apo.Man.Soli: MARTINEZ GUILLEN ALFREDO;DE CASTRO POZUELO ANA;HUGUET JUANENA JOSE MARIA. Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARTINEZ GUILLEN ALFREDO;JUDEZ AGUADO PEDRO;HUGUET JUANENA JOSE MARIA. Datos registrales...
Revocaciones — 12/02/2010
Revocaciones. Apo.Man.Soli: HUGUET JUANENA JOSE MARIA;ALVAREZ HERRAIZ CARLOS;DE CASTRO POZUELO ANA. Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARTINEZ GUILLEN ALFREDO;DE CASTRO POZUELO ANA;HUGUET JUANENA JOSE MARIA. Datos registrale...
Revocaciones — 12/02/2010
Revocaciones. Apoderado: ALVAREZ HERRAIZ CARLOS. Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ GUILLEN ALFREDO. Datos registrales. T 3046 , F 98, S 8, H Z 35354, I/A 11 ( 3.02.10).
Cambio de domicilio social — 05/10/2009
Cambio de domicilio social. CTRA DEL AEROPUERTO 4 - CENTRO EMPRESARIAL SAN LAM (ZARAGOZA). Datos registrales. T 3046 , F 98, S 8, H Z 35354, I/A 9 (24.09.09).
Sociedad unipersonal — 20/01/2009
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: GRUPO OBRAS ESPECIALES PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA. Cambio de objeto social. A) La construcción, promoción, adquisición, venta, y en general la explotación por...