Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2019 14 tarjetas
04/01/2019 Sec. I Revocaciones Zaragoza
Zaragoza-4291

Revocaciones — 04/01/2019

Revocaciones. Apoderado: RAMOS MUÑOZ JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 4368 , F 82, S 8, H Z 35062, I/A 31 (27.12.18).

16/11/2018 Sec. I Nombramientos Zaragoza
Zaragoza-459379

Nombramientos — 16/11/2018

Nombramientos. Apoderado: RAMOS MUÑOZ JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 3638 , F 196, S 8, H Z 35062, I/A 30 ( 8.11.18).

10/10/2017 Sec. I Ceses/Dimisiones Zaragoza
Zaragoza-400838

Ceses/dimisiones — 10/10/2017

Ceses/Dimisiones. Auditor: FIDES VILLALBA AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA PROFESI. Nombramientos. Auditor: VILLALBA ENVID Y CIA AUDITORES SLP. Datos registrales. T 3638 , F 196, S 8, H Z 35062, I/A 29 (29.09.17).

24/03/2017 Sec. I Revocaciones Zaragoza
Zaragoza-134272

Revocaciones — 24/03/2017

Revocaciones. Apoderado: RAMOS MUÑOZ JOSE ANTONIO;CEJALVO GORDO JUAN ANTONIO. Apo.Man.Soli: CALDERO ROURE JOSE MARIA. Apo.Manc.: FRAJ GASCON MIGUEL ANGEL;ORERA PEÑA JOSE RUBEN. Datos registrales. T 3638 , F 196, S 8, H...

20/08/2015 Sec. I Cancelaciones de oficio de nombramientos Zaragoza
Zaragoza-347101

Cancelaciones de oficio de nombramientos — 20/08/2015

Cancelaciones de oficio de nombramientos. Consejero: LUENGO MARTINEZ ANGEL;ORERA PEÑA JOSE RUBEN;FRAJ GASCON MIGUEL ANGEL. Presidente: LUENGO MARTINEZ ANGEL. Vicepresid.: ORERA PEÑA JOSE RUBEN. Cons.Del.Sol: ORERA PEÑA...

05/05/2015 Sec. I Nombramientos Zaragoza
Zaragoza-183835

Nombramientos — 05/05/2015

Nombramientos. Apoderado: BARRABES CASTANERA FRANCISCO. Datos registrales. T 3638 , F 195, S 8, H Z 35062, I/A 26 (27.04.15).

06/10/2014 Sec. I Nombramientos Zaragoza
Zaragoza-398332

Nombramientos — 06/10/2014

Nombramientos. Auditor: FIDES VILLALBA AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA PROFESI. Datos registrales. T 3638 , F 195, S 8, H Z 35062, I/A 25 (25.09.14).

03/02/2014 Sec. I Ampliación de capital Zaragoza
Zaragoza-49688

Ampliación de capital — 03/02/2014

Ampliación de capital. Suscrito: 14.110.000,00 Euros. Desembolsado: 14.110.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 33.200.000,00 Euros. Resultante Desembolsado: 33.200.000,00 Euros. Datos registrales. T 3638 , F 195, S 8, H...

20/09/2011 Sec. I Reelecciones Zaragoza
Zaragoza-378726

Reelecciones — 20/09/2011

Reelecciones. Auditor: VILLALBA ENVID Y CIA AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA P. Datos registrales. T 3638 , F 195, S 8, H Z 35062, I/A 23 ( 7.09.11).

16/02/2011 Sec. I Revocaciones Zaragoza
Zaragoza-71487

Revocaciones — 16/02/2011

Revocaciones. Apoderado: RAMOS MUÑOZ JOSE ANTONIO. Nombramientos. Apoderado: RAMOS MUÑOZ JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 3638 , F 194, S 8, H Z 35062, I/A 22 ( 7.02.11).

05/01/2011 Sec. I Modificaciones estatutarias Zaragoza
Zaragoza-5047

Modificaciones estatutarias — 05/01/2011

Modificaciones estatutarias. Artículo Decimosegundo.- La Administración de la Sociedad se confía al Consejo de Administración, que estará integradopor tres miembros como mínimo y siete como máximo. Corresponde a la Jutn...

01/12/2009 Sec. I Reducción de capital Zaragoza
Zaragoza-503127

Reducción de capital — 01/12/2009

Reducción de capital. Importe reducción: 8.510.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 19.090.000,00 Euros. Datos registrales. T 3638 , F 194, S 8, H Z 35062, I/A 20 (20.11.09).

13/05/2009 Sec. I Nombramientos Zaragoza
Zaragoza-220587

Nombramientos — 13/05/2009

Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ CLAVERIA DAVID. Datos registrales. T 3638 , F 193, S 8, H Z 35062, I/A 19 ( 4.05.09).

29/04/2009 Sec. I Revocaciones Zaragoza
Zaragoza-202287

Revocaciones — 29/04/2009

Revocaciones. Apo.Man.Soli: CALDERO ROURE JOSE MARIA. Datos registrales. T 3638 , F 193, S 8, H Z 35062, I/A 18 (20.04.09).