Actos destacados
Revocaciones — 18/05/2018
Revocaciones. Apoderado: ANDRES VIVES MARTINEZ. Nombramientos. Apoderado: ANDRES VIVES MARTINEZ. Datos registrales. T 2957 , F 189, S 8, H MU 48661, I/A 30 (11.05.18).
Reelecciones — 07/12/2017
Reelecciones. Auditor: FINAUDIT SLP. Datos registrales. T 2957 , F 189, S 8, H MU 48661, I/A 29 (29.11.17).
Reelecciones — 11/11/2014
Reelecciones. Auditor: FINAUDIT SLP. Datos registrales. T 2957 , F 189, S 8, H MU 48661, I/A 28 ( 3.11.14).
Revocaciones — 03/07/2013
Revocaciones. Apoderado: ANTONIO MANUEL CALVENTE ALVAREZ. Datos registrales. T 2569 , F 45, S 8, H MU 48661, I/A 26 (26.06.13).
Ceses/dimisiones — 11/06/2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: JUAN MIGUEL SERRANO VIVES;PEDRO VICENTE VIVES IGUALADA;PEDRO VIVES FERRANDIZ;JUAN VIVES MARTI;ANTONIO MANUEL CALVENTE ALVAREZ. Presidente: PEDRO VIVES FERRANDIZ. Secretario: ANTONIO MANUEL C...
Nombramientos — 11/06/2013
Nombramientos. Apoderado: ANTONIO MANUEL CALVENTE ALVAREZ. Datos registrales. T 2569 , F 45, S 8, H MU 48661, I/A 25 ( 5.06.13).
Nombramientos — 15/03/2012
Nombramientos. Auditor: FINAUDIT SLP. Datos registrales. T 2569 , F 44, S 8, H MU 48661, I/A 23 ( 7.03.12). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 53 Jueves 15 de marzo de 2012 Pág. 13545 cve: BORME-A-2012-53-30
Reelecciones — 17/08/2010
Reelecciones. Auditor: APRADAS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 2569 , F 44, S 8, H MU 48661, I/A 22 ( 9.08.10).
Nombramientos — 19/07/2010
Nombramientos. Apoderado: ANDRES VIVES MARTINEZ. Datos registrales. T 2569 , F 43, S 8, H MU 48661, I/A 21 ( 9.07.10).
Revocaciones — 01/02/2010
Revocaciones. Apoderado: VICENTE RAFAEL SANCHIS SEGOVIA. Datos registrales. T 2569 , F 43, S 8, H MU 48661, I/A 20 (21.01.10).
Ampliación de capital — 09/09/2009
Ampliación de capital. Capital: 1.000.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.000.000,00 Euros. Datos registrales. T 2569 , F 43, S 8, H MU 48661, I/A 19 ( 1.09.09). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 172 Miércole...