Actos destacados
Reelecciones — 14/10/2019
Reelecciones. Auditor: AUDITORES Y CONSULTORES DEL SUR SLP. Datos registrales. T 5256 , F 42, S 8, H SE 13214, I/A 43 ( 4.10.19).
Reelecciones — 14/10/2019
Reelecciones. Aud.C.Con.: AUDITORES Y CONSULTORES DEL SUR SLP. Datos registrales. T 5256 , F 42, S 8, H SE 13214, I/A 44 ( 4.10.19).
Ceses/dimisiones — 26/07/2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: NIMO MUÑOZ JOSE LUIS. Presidente: NIMO MUÑOZ JOSE LUIS. Secretario: NIMO MALDONADO JOSE RAMON. Nombramientos. Secretario: NIMO MALDONADO ROSARIO. Presidente: NIMO MALDONADO JOSE RAMON. Vicep...
Modificaciones estatutarias — 13/03/2019
Modificaciones estatutarias. 26. Retribución.-. Datos registrales. T 5256 , F 175, S 8, H SE 13214, I/A 41 ( 5.03.19).
Nombramientos — 20/02/2019
Nombramientos. Apoderado: MESEGUER MARTINEZ JOAQUIN. Datos registrales. T 5256 , F 174, S 8, H SE 13214, I/A 39 (13.02.19).
Nombramientos — 20/02/2019
Nombramientos. Apoderado: PICCHI ASPE PALOMA. Datos registrales. T 5256 , F 175, S 8, H SE 13214, I/A 40 (13.02.19).
Fe de erratas: reelegido dos veces por error en la inscripcion 31ª — 15/01/2019
Fe de erratas: REELEGIDO DOS VECES POR ERROR EN LA INSCRIPCION 31ª. Datos registrales. T 5256 , F 171, S 8, H SE 13214, I/A 31 (24.07.14).
Reelecciones — 15/01/2019
Reelecciones. Consejero: NIMO MUÑOZ JOSE LUIS;NIMO MALDONADO JOSE RAMON;NIMO MALDONADO JOSE LUIS;NIMO MALDONADO ROSARIO. Presidente: NIMO MUÑOZ JOSE LUIS. Secretario: NIMO MALDONADO JOSE RAMON. Con.Delegado: NIMO MALDON...
Ampliación de capital — 11/08/2017
Ampliación de capital. Suscrito: 95,16 Euros. Desembolsado: 95,16 Euros. Resultante Suscrito: 240.500,00 Euros. Resultante Desembolsado: 240.500,00 Euros. Reducción de capital. Importe reducción: 9.139,00 Euros. Resulta...
Nombramientos — 27/04/2017
Nombramientos. Apoderado: MESEGUER MARTINEZ JOAQUIN. Datos registrales. T 5256 , F 172, S 8, H SE 13214, I/A 36 (19.04.17).
Nombramientos — 05/01/2017
Nombramientos. Aud.C.Con.: AUDITORES Y CONSULTORES DEL SUR SLP. Datos registrales. T 5256 , F 172, S 8, H SE 13214, I/A 35 (27.12.16).
Nombramientos — 04/01/2017
Nombramientos. Auditor: AUDITORES Y CONSULTORES DEL SUR SLP. Datos registrales. T 5256 , F 172, S 8, H SE 13214, I/A 34 (27.12.16).
Revocaciones — 13/03/2015
Revocaciones. Apoderado: CASTILLA MANTECON MANUEL. Datos registrales. T 5256 , F 172, S 8, H SE 13214, I/A 33 ( 2.03.15).
Modificaciones estatutarias — 17/11/2014
Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 3. Domicilio.-. Cambio de domicilio social. AVDA FERNANDEZ MURUBE 30 (SEVILLA). Datos registrales. T 5256 , F 171, S 8, H SE 13214, I/A 32 (29.10.14).
Reelecciones — 04/08/2014
Reelecciones. Consejero: NIMO MALDONADO JOSE RAMON;NIMO MUÑOZ JOSE LUIS;NIMO MALDONADO JOSE RAMON;NIMO MALDONADO JOSE LUIS;NIMO MALDONADO ROSARIO. Presidente: NIMO MUÑOZ JOSE LUIS. Secretario: NIMO MALDONADO JOSE RAMON....
Nombramientos — 05/02/2014
Nombramientos. Aud.C.Con.: AUDITORES Y CONSULTORES DEL SUR SLP. Datos registrales. T 5256 , F 170, S 8, H SE 13214, I/A 29 (20.01.14).
Nombramientos — 05/02/2014
Nombramientos. Auditor: AUDITORES Y CONSULTORES DEL SUR SLP. Datos registrales. T 5256 , F 170, S 8, H SE 13214, I/A 30 (20.01.14).
Nombramientos — 04/02/2013
Nombramientos. Apoderado: MESEGUER MARTINEZ JOAQUIN. Datos registrales. T 5256 , F 169, S 8, H SE 13214, I/A 28 (22.01.13).
Ceses/dimisiones — 16/01/2013
Ceses/Dimisiones. Auditor: ROMERO MARQUEZ ANDRES. Datos registrales. T 5256 , F 169, S 8, H SE 13214, I/A 27 ( 2.01.13).
Reelecciones — 06/04/2011
Reelecciones. Auditor: ROMERO MARQUEZ ANDRES. Aud.Supl.: GATT AUDITORES SL. Datos registrales. T 5256 , F 168, S 8, H SE 13214, I/A 25 (18.03.11).
Nombramientos — 13/10/2010
Nombramientos. Apoderado: MESEGUER MARTINEZ JOAQUIN. Datos registrales. T 5256 , F 168, S 8, H SE 13214, I/A 24 (30.09.10).
Nombramientos — 27/09/2010
Nombramientos. Apoderado: GARCIA GAVILAN ANTONIO. Datos registrales. T 5256 , F 166, S 8, H SE 13214, I/A 22 (15.09.10).
Nombramientos — 27/09/2010
Nombramientos. Apoderado: GARCIA BERMUDEZ MANUEL. Datos registrales. T 5256 , F 167, S 8, H SE 13214, I/A 23 (15.09.10).
Revocaciones — 27/08/2010
Revocaciones. Apoderado: GARCIA GAVILAN ANTONIO. Datos registrales. T 1725 , F 179, S 8, H SE 13214, I/A 20 (13.08.10).