Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2015 6 tarjetas
07/08/2015 Sec. I Reelecciones Madrid
Madrid-330360

Reelecciones — 07/08/2015

Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 14499 , F 219, S 8, H M 239913, I/A 53 (30.07.15).

07/08/2015 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-330361

Revocaciones — 07/08/2015

Revocaciones. Apo.Man.Soli: CANO GONZALEZ JOSE MANUEL. Datos registrales. T 14499 , F 219, S 8, H M 239913, I/A 54 (30.07.15).

21/01/2013 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-28524

Ceses/dimisiones — 21/01/2013

Ceses/Dimisiones. Consejero: AMELIBIA NUÑEZ JOSE ANTONIO. Nombramientos. Consejero: CUÑADO AUSIN GREGORIO. Datos registrales. T 14499 , F 216, S 8, H M 239913, I/A 49 (11.01.13).

08/11/2012 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-459395

Revocaciones — 08/11/2012

Revocaciones. Apoderado: CANO GONZALEZ JOSE MANUEL;CANO GONZALEZ JOSE MANUEL. Nombramientos. Apo.Man.Soli: CANO GONZALEZ JOSE MANUEL. Apo.Manc.: MUNTAÑOLA PROSPER DAVID. Datos registrales. T 14499 , F 215, S 8, H M 2399...

01/06/2012 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-233891

Nombramientos — 01/06/2012

Nombramientos. Consejero: MEDINA MARTIN OSCAR. Datos registrales. T 14499 , F 212, S 8, H M 239913, I/A 40 (22.05.12).

05/12/2011 Sec. I Reelecciones Madrid
Madrid-484698

Reelecciones — 05/12/2011

Reelecciones. Consejero: AMELIBIA NUÑEZ JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 14499 , F 209, S 8, H M 239913, I/A 38 (22.11.11).