Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2017 24 tarjetas
19/07/2017 Sec. I Disolución Girona
Girona-295696

Disolución — 19/07/2017

Disolución. Fusion. Extinción. Datos registrales. T 2958 , F 119, S 8, H GI 30232, I/A 37 (12.07.17).

14/06/2016 Sec. I Revocaciones Girona
Girona-250273

Revocaciones — 14/06/2016

Revocaciones. Apo.Sol.: MARIA CARMEN MASGORET BORRAS. Datos registrales. T 2958 , F 118, S 8, H GI 30232, I/A 35 ( 7.06.16).

14/06/2016 Sec. I Nombramientos Girona
Girona-250274

Nombramientos — 14/06/2016

Nombramientos. Apoderado: JORDI SOLER PLANIOL. Datos registrales. T 2958 , F 118, S 8, H GI 30232, I/A 36 ( 7.06.16).

17/03/2016 Sec. I Nombramientos Girona
Girona-124308

Nombramientos — 17/03/2016

Nombramientos. Apoderado: ANDRES ESPUELAS FERNANDEZ. Datos registrales. T 2958 , F 118, S 8, H GI 30232, I/A 34 ( 9.03.16).

02/02/2016 Sec. I Ampliación de capital Girona
Girona-44342

Ampliación de capital — 02/02/2016

Ampliación de capital. Capital: 1.000.064,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.871.514,00 Euros. Datos registrales. T 2958 , F 118, S 8, H GI 30232, I/A 33 (26.01.16).

30/10/2015 Sec. I Revocaciones Girona
Girona-437786

Revocaciones — 30/10/2015

Revocaciones. Apo.Sol.: ALBERT MARGALEFF LEMCKE. Datos registrales. T 2958 , F 118, S 8, H GI 30232, I/A 32 (23.10.15).

04/08/2015 Sec. I Nombramientos Girona
Girona-323386

Nombramientos — 04/08/2015

Nombramientos. Apoderado: RAMON XIFRA PAGES. Datos registrales. T 2958 , F 117, S 8, H GI 30232, I/A 31 (28.07.15).

12/12/2014 Sec. I Revocaciones Girona
Girona-507358

Revocaciones — 12/12/2014

Revocaciones. Apo.Manc.: XAVIER PAGES PARETA;GLORIA COMAS ALSINA;NARCIS XIFRA PAGES. Datos registrales. T 2958 , F 115, S 8, H GI 30232, I/A 23 ( 4.12.14).

12/12/2014 Sec. I Nombramientos Girona
Girona-507359

Nombramientos — 12/12/2014

Nombramientos. Apo.Manc.: NARCIS XIFRA PAGES;XAVIER PAGES PARETA;JEROEN HENDRICUS VAN DER MEER;AGNES JUANDO VIÑALS. Datos registrales. T 2958 , F 115, S 8, H GI 30232, I/A 24 ( 4.12.14).

09/06/2014 Sec. I Revocaciones Girona
Girona-240417

Revocaciones — 09/06/2014

Revocaciones. Apo.D.Gral.: JAIME MARTINEZ AGUILO. Apoderado: MARIA CARMEN MASGORET BORRAS. Apo.Manc.: NARCIS XIFRA PAGES;JAIME MARTINEZ AGUILO;GLORIA COMAS ALSINA. Datos registrales. T 1819 , F 69, S 8, H GI 30232, I/A...

09/06/2014 Sec. I Nombramientos Girona
Girona-240418

Nombramientos — 09/06/2014

Nombramientos. Apo.Manc.: XAVIER PAGES PARETA;GLORIA COMAS ALSINA;NARCIS XIFRA PAGES. Datos registrales. T 2958 , F 114, S 8, H GI 30232, I/A 21 ( 2.06.14). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 107 Lunes 9 de jun...

09/06/2014 Sec. I Nombramientos Girona
Girona-240419

Nombramientos — 09/06/2014

Nombramientos. Apo.Sol.: XAVIER PAGES PARETA;MARIA CARMEN MASGORET BORRAS. Datos registrales. T 2958 , F 114, S 8, H GI 30232, I/A 22 ( 2.06.14).

26/11/2013 Sec. I Nombramientos Girona
Girona-503347

Nombramientos — 26/11/2013

Nombramientos. Apo.Sol.: RAMON XIFRA PAGES;MIQUEL SALVA VINYOLES. Datos registrales. T 1819 , F 69, S 8, H GI 30232, I/A 18 (19.11.13).

26/11/2013 Sec. I Revocaciones Girona
Girona-503348

Revocaciones — 26/11/2013

Revocaciones. Apo.Sol.: RAMON XIFRA PAGES;ALBERT NEGRE MELENDEZ. Datos registrales. T 1819 , F 69, S 8, H GI 30232, I/A 19 (19.11.13).

02/10/2012 Sec. I Revocaciones Girona
Girona-400961

Revocaciones — 02/10/2012

Revocaciones. Apo.Sol.: FELIX ROCA BATLLORI. Apo.Manc.: JAIME MARTINEZ AGUILO;FELIX ROCA BATLLORI;NARCIS XIFRA PAGES. Datos registrales. T 1819 , F 69, S 8, H GI 30232, I/A 16 (21.09.12).

02/10/2012 Sec. I Nombramientos Girona
Girona-400962

Nombramientos — 02/10/2012

Nombramientos. Apo.Manc.: NARCIS XIFRA PAGES;JAIME MARTINEZ AGUILO;GLORIA COMAS ALSINA. Datos registrales. T 1819 , F 69, S 8, H GI 30232, I/A 17 (21.09.12).

20/02/2012 Sec. I Revocaciones Girona
Girona-82783

Revocaciones — 20/02/2012

Revocaciones. Apoderado: JOSE MARIA ROURE RABASSEDA;JOSEP ROVIRA CANE. Datos registrales. T 1819 , F 68, S 8, H GI 30232, I/A 15 ( 9.02.12).

08/09/2011 Sec. I Ceses/Dimisiones Girona
Girona-365389

Ceses/dimisiones — 08/09/2011

Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: NARCIS XIFRA PAGES. Nombramientos. Adm. Unico: COMEXI GROUP SL. Datos registrales. T 1819 , F 66, S 8, H GI 30232, I/A 9 (30.08.11).

08/09/2011 Sec. I Nombramientos Girona
Girona-365390

Nombramientos — 08/09/2011

Nombramientos. Apoderado: MIQUEL SALVA VINYOLES. Datos registrales. T 1819 , F 66, S 8, H GI 30232, I/A 10 (30.08.11).

08/09/2011 Sec. I Nombramientos Girona
Girona-365391

Nombramientos — 08/09/2011

Nombramientos. Apo.Sol.: RAMON XIFRA PAGES;ALBERT NEGRE MELENDEZ. Datos registrales. T 1819 , F 67, S 8, H GI 30232, I/A 11 (30.08.11).

08/09/2011 Sec. I Nombramientos Girona
Girona-365392

Nombramientos — 08/09/2011

Nombramientos. Apoderado: MARIA CARMEN MASGORET BORRAS. Datos registrales. T 1819 , F 67, S 8, H GI 30232, I/A 12 (30.08.11).

08/09/2011 Sec. I Nombramientos Girona
Girona-365393

Nombramientos — 08/09/2011

Nombramientos. Apo.Manc.: JAIME MARTINEZ AGUILO;FELIX ROCA BATLLORI;NARCIS XIFRA PAGES. Datos registrales. T 1819 , F 67, S 8, H GI 30232, I/A 13 (30.08.11). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 172 Jueves 8 de s...

08/09/2011 Sec. I Nombramientos Girona
Girona-365394

Nombramientos — 08/09/2011

Nombramientos. Apo.D.Gral.: JAIME MARTINEZ AGUILO. Datos registrales. T 1819 , F 68, S 8, H GI 30232, I/A 14 (30.08.11).

06/07/2010 Sec. I Declaración de unipersonalidad Girona
Girona-266973

Declaración de unipersonalidad — 06/07/2010

Declaración de unipersonalidad. Socio único: COMEXI GROUP SL. Ampliación de capital. Capital: 601.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 871.450,00 Euros. Datos registrales. T 1819 , F 66, S 8, H GI 30232, I/A 8 (23.06.10).