Actos destacados
Disolución — 01/02/2016
Disolución. Fusion. Extinción. Datos registrales. T 424 , F 186, S 8, H LU 13856, I/A 6 (22.01.16).
Nombramientos — 04/02/2013
Nombramientos. Apoderado: CRUZ JENTOFT JOSE MANUEL. Datos registrales. T 424 , F 185, S 8, H LU 13856, I/A 4 (21.01.13).
Nombramientos — 30/05/2011
Nombramientos. Apoderado: LOZANO CEREZO MARIA LUZ. Datos registrales. T 424 , F 185, S 8, H LU 13856, I/A 3 (14.05.11). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 102 Lunes 30 de mayo de 2011 Pág. 27385 cve: BORME-A-20...
Revocaciones — 07/12/2010
Revocaciones. Apoderado: LOZANO MUÑOZ JOSE MARIA;RODRIGUEZ GARCIA JORGE EUGENIO. Apo.Sol.: LOZANO MUÑOZ JOSE. Datos registrales. T 424 , F 185, S 8, H LU 13856, I/A 2 (19.11.10). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL N...
Sociedad unipersonal — 23/11/2010
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: NORVENTO HIDRAULICA SA. Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: MATZINGER GERHARD;LOZANO MUÑOZ JOSE. Nombramientos. Adm. Solid.: FERNANDEZ CASTRO PABLO MARIA;FERNANDEZ...