Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2018 4 tarjetas
25/10/2018 Sec. I Extinción Madrid
Madrid-425920

Extinción — 25/10/2018

Extinción. Datos registrales. T 31554 , F 5, S 8, H M 137887, I/A 30 (17.10.18).

12/11/2013 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-481912

Ceses/dimisiones — 12/11/2013

Ceses/Dimisiones. Miem.Com.Ctr: NAVARRO TARRAGA MIGUEL. Consejero: PLADELLORENS IBARZ MARIA-ANTONIA;BATZ OLASO RAFAEL;GARCIA GALLEGO JOSE CARLOS. Nombramientos. Auditor: ATTEST SERVICIOS EMPRESARIALES SL. Def.Particip:...

24/11/2010 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-434114

Ceses/dimisiones — 24/11/2010

Ceses/Dimisiones. Consejero: DE LA OSSA MARTINEZ ANTONIO;NOVALBOS GARRIDO RICARDO;POLO CAÑABATE JOAQUIN JESUS;DE PAZ PAEZ MARIA CARMEN;SANCHEZ GONZALEZ ILDEFONSO;JIMENEZ FERNANDEZ MIGUEL ANGEL. Presidente: SANCHEZ GONZA...

24/11/2010 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-434115

Ceses/dimisiones — 24/11/2010

Ceses/Dimisiones. Miem.Com.Ctr: BATZ OLASO RAFAEL;AYUSO MARQUEZ JOSE-RAFAEL;TORICES FERNANDEZ TOMAS. Nombramientos. Miem.Com.Ctr: RUIZ OLARRIA PILAR;AYUSO MARQUEZ JOSE-RAFAEL;HERNANDEZ SERRANO MARIO CESAR. Reelecciones....