Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2016 6 tarjetas
27/10/2016 Sec. I Revocaciones Barcelona
Barcelona-433674

Revocaciones — 27/10/2016

Revocaciones. LIQUIDADOR: BLADE COSTA JORDI MIQUEL. Extinción. Datos registrales. T 43346 , F 102, S 8, H B 74887, I/A 49 (19.10.16).

13/11/2012 Sec. I Cambio de domicilio social Barcelona
Barcelona-463082

Cambio de domicilio social — 13/11/2012

Cambio de domicilio social. AV DIAGONAL Num.520 P.BJ (BARCELONA). Datos registrales. T 43346 , F 101, S 8, H B 74887, I/A 46 (31.10.12).

14/08/2012 Sec. I Revocaciones Barcelona
Barcelona-341168

Revocaciones — 14/08/2012

Revocaciones. APODERADO: LOPEZ POLO ANTONIO;AVELLO DE LA PEÑA ALFREDO;THOMAS GARCIA JUAN. Datos registrales. T 43346 , F 101, S 8, H B 74887, I/A 44 ( 3.08.12).

27/07/2012 Sec. I Revocaciones Barcelona
Barcelona-316996

Revocaciones — 27/07/2012

Revocaciones. APODERADO: PICARDO SANCHEZ BRIÑAS MARTA. Datos registrales. T 42991 , F 50, S 8, H B 74887, I/A 42 (18.07.12).

27/07/2012 Sec. I Nombramientos Barcelona
Barcelona-316998

Nombramientos — 27/07/2012

Nombramientos. APODERADO: BLADE COSTA JORDI MIQUEL;PELLICER CORTINA SILVIA;DE BRUGADA MARIEGES SILVIA;GALVEZ GIMENEZ MANUEL. Datos registrales. T 42991 , F 50, S 8, H B 74887, I/A 43 (18.07.12).

12/05/2009 Sec. I Revocaciones Barcelona
Barcelona-218291

Revocaciones — 12/05/2009

Revocaciones. APODERADO: GOMEZ MIRO FRANCESC XAVIER. Datos registrales. T 41128 , F 62, S 8, H B 74887, I/A 24 (29.04.09).