Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2013 6 tarjetas
22/02/2013 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-90627

Revocaciones — 22/02/2013

Revocaciones. Apoderado: BIMBOESE VON TROTT ZU SOLZ MARGARITA. Datos registrales. T 1531 , F 117, S 8, H M 28226, I/A 33 (14.02.13). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 37 Viernes 22 de febrero de 2013 Pág. 9468...

22/02/2013 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-90628

Revocaciones — 22/02/2013

Revocaciones. Apoderado: QUINTERO MORENO JOSE. Datos registrales. T 1531 , F 117, S 8, H M 28226, I/A 34 (14.02.13).

27/12/2012 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-540179

Ceses/dimisiones — 27/12/2012

Ceses/Dimisiones. Presidente: GRAF KLAUS. Consejero: GRAF KLAUS;VON TROTT ZU SOLZ MARGARITA BIMBOESSE. Con.Delegado: GRAF KLAUS. SecreNoConsj: FERNANDEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL. Nombramientos. Consejero: BECK MARTIN;FERNANDE...

12/11/2012 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-461540

Revocaciones — 12/11/2012

Revocaciones. Apoderado: DIAZ GUIJARRO ALBERTO;DIAZ GUIJARRO ALBERTO. Datos registrales. T 1531 , F 116, S 8, H M 28226, I/A 31 (29.10.12).

04/06/2012 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-235655

Nombramientos — 04/06/2012

Nombramientos. Apoderado: BALDASANO SUPERVIELLE ARTURO. Datos registrales. T 1531 , F 115, S 8, H M 28226, I/A 28 (23.05.12).

04/06/2012 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-235656

Nombramientos — 04/06/2012

Nombramientos. Apoderado: BETERE KOPP JUAN. Datos registrales. T 1531 , F 116, S 8, H M 28226, I/A 29 (23.05.12).