Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2018 5 tarjetas
17/07/2018 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-295957

Ceses/dimisiones — 17/07/2018

Ceses/Dimisiones. Consejero: MCGINLEY PAUL A.;TWILLIGER STEPHEN-TODD. Nombramientos. Consejero: CAREY DAVID FRANKLIN;MOLETTO GIACOMO;HORNE SIMON PETER BARRY;MARTINEZ MILLET CARLOS. Datos registrales. T 30261 , F 188, S...

17/07/2018 Sec. I Cambio de denominación social Madrid
Madrid-295958

Cambio de denominación social — 17/07/2018

Cambio de denominación social. MOTORPRESS HEARST SL. Datos registrales. T 30261 , F 188, S 8, H M 275007, I/A 52 (10.07.18).

26/09/2017 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-383687

Ceses/dimisiones — 26/09/2017

Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: VON WOLFFERSDORFF PHILIPP. Consejero: BREID VOLKER. Presidente: BREID VOLKER. Cons.Del.Sol: BREID VOLKER. Nombramientos. SecreNoConsj: MEYER STEFAN. Presidente: WANDOSELL ALCINA MARIA. Co...

02/03/2017 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-101248

Revocaciones — 02/03/2017

Revocaciones. Apoderado: MOYA RODA RAUL;MOYA RODA CRISTINA;FRANCO LOPEZ CARLOS. Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ MILLET CARLOS;ABAN FUSTER RAMON;GONZALEZ MARTINEZ SONIA. Datos registrales. T 30261 , F 184, S 8, H M 27...

22/10/2012 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-428300

Revocaciones — 22/10/2012

Revocaciones. Apo.Manc.: DOS SANTOS OLIVEIRA FERNANDO;SEQUEIRA RUI. Nombramientos. Apoderado: SEQUEIRA RUI. Datos registrales. T 16894 , F 16, S 8, H M 275007, I/A 37 ( 9.10.12).