Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2015 24 tarjetas
02/01/2015 Sec. I Disolución Toledo
Toledo-399

Disolución — 02/01/2015

Disolución. Fusion. Extinción. Datos registrales. T 1549 , F 55, S 8, H TO 2989, I/A 63 (23.12.14).

21/11/2014 Sec. I Declaración de unipersonalidad Toledo
Toledo-476221

Declaración de unipersonalidad — 21/11/2014

Declaración de unipersonalidad. Socio único: AUTOMOVILES CITROEN ESPAÑA SA. Datos registrales. T 1549 , F 55, S 8, H TO 2989, I/A 62 (13.11.14).

21/11/2014 Sec. I Otros conceptos: Practicada la nota marginal de cierre provisional, Art Toledo
Toledo-476222

Otros conceptos: practicada la nota marginal de cierre provisional, art — 21/11/2014

Otros conceptos: Practicada la nota marginal de cierre provisional, Art. 231 R.R.M., por plazo de 6 meses a contar desde el 13/11/2014; no habiéndose encontrado obstáculos registrales para la fusión formalizada en la es...

17/07/2014 Sec. I Nombramientos Toledo
Toledo-296609

Nombramientos — 17/07/2014

Nombramientos. Apo.Sol.: TORRES BUA RAMON;CANAL MOSQUEIRA YOLANDA MERCEDES. Datos registrales. T 1549 , F 53, S 8, H TO 2989, I/A 59 (10.07.14).

17/07/2014 Sec. I Revocaciones Toledo
Toledo-296610

Revocaciones — 17/07/2014

Revocaciones. Apo.Sol.: NARRILLOS ROUX MARIA ESTEFANIA;MILERUD NESTOR ROBERTO;ALONSO JORRETO FERNANDO;ALONSO ALONSO MERCEDES;BENITO ROLDAN MAGDALENA;MADINA ROMERO SOFIA;MOREIRA PEREIRA CARLA MARIA;RIBES TRAVER PEDRO JOS...

23/09/2013 Sec. I Reelecciones Toledo
Toledo-408607

Reelecciones — 23/09/2013

Reelecciones. Auditor: MAZARS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 1549 , F 53, S 8, H TO 2989, I/A 58 ( 2.09.13).

12/11/2012 Sec. I Reelecciones Toledo
Toledo-462373

Reelecciones — 12/11/2012

Reelecciones. Auditor: MAZARS AUDITORES SL. Datos registrales. T 1549 , F 52, S 8, H TO 2989, I/A 53 (29.10.12).

16/08/2012 Sec. I Ceses/Dimisiones Toledo
Toledo-344406

Ceses/dimisiones — 16/08/2012

Ceses/Dimisiones. Secretario: VILLEGAS BALLESTEROS ALAIN. Nombramientos. Secretario: LAHIGUERA RODRIGUEZ JUAN JOSE. Datos registrales. T 1549 , F 50, S 8, H TO 2989, I/A 49 ( 6.08.12).

16/08/2012 Sec. I Revocaciones Toledo
Toledo-344407

Revocaciones — 16/08/2012

Revocaciones. Apo.Sol.: NARRILLOS ROUX MARIA ESTEFANIA;ALONSO ALONSO MERCEDES;BENITO ROLDAN MAGDALENA;MADINA ROMERO SOFIA;HIERRO SUREDA LUIS;PEREYRA LUIS DANIEL;SANTAMARIA PASCUA JON JACOBO;ALONSO JORRETO FERNANDO;RIBES...

16/08/2012 Sec. I Revocaciones Toledo
Toledo-344408

Revocaciones — 16/08/2012

Revocaciones. Apo.Sol.: VAQUERO CUELLAR CARMELO;TORRIJOS SANTOS ALFONSO;GARCIA DEL PRADO GABRIEL;PERIAÑEZ FERNANDEZ MANUEL;IGLESIAS PEREZ JUAN-JOSE;OBRA SERRANO PABLO;VILLEGAS BALLESTEROS ALAIN. Apo.Manc.: VAQUERO CUELL...

16/08/2012 Sec. I Revocaciones Toledo
Toledo-344409

Revocaciones — 16/08/2012

Revocaciones. Apo.Sol.: BOUZAS TOBIO ALFREDO JOSE. Datos registrales. T 1549 , F 51, S 8, H TO 2989, I/A 52 ( 6.08.12).

26/01/2012 Sec. I Nombramientos Toledo
Toledo-40531

Nombramientos — 26/01/2012

Nombramientos. Apoderado: PADILLA PEÑA JAVIER. Datos registrales. T 1527 , F 123, S 8, H TO 2989, I/A 45 (17.01.12).

26/01/2012 Sec. I Nombramientos Toledo
Toledo-40532

Nombramientos — 26/01/2012

Nombramientos. Apoderado: REYES MORENO JAVIER. Datos registrales. T 1527 , F 123, S 8, H TO 2989, I/A 46 (17.01.12).

26/01/2012 Sec. I Nombramientos Toledo
Toledo-40533

Nombramientos — 26/01/2012

Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ SIMON JAVIER-ALFONSO. Datos registrales. T 1527 , F 123, S 8, H TO 2989, I/A 47 (17.01.12).

26/01/2012 Sec. I Revocaciones Toledo
Toledo-40534

Revocaciones — 26/01/2012

Revocaciones. Apo.Sol.: DALMAU DEL BARRIO MARIA JOSE;DEL POZO VEGA DARIO. Nombramientos. Apoderado: DEL POZO VEGA DARIO. Datos registrales. T 1527 , F 123, S 8, H TO 2989, I/A 48 (17.01.12).

10/11/2011 Sec. I Ceses/Dimisiones Toledo
Toledo-447381

Ceses/dimisiones — 10/11/2011

Ceses/Dimisiones. Consejero: IGLESIAS PEREZ JUAN-JOSE. Presidente: IGLESIAS PEREZ JUAN-JOSE. Consejero: BUENO MACHO MARIA-ASUNCION. Nombramientos. Presidente: TORMENTA PEREIRA TOME JORGE MANUEL. Consejero: TORMENTA PERE...

10/11/2011 Sec. I Nombramientos Toledo
Toledo-447382

Nombramientos — 10/11/2011

Nombramientos. Apoderado: ASOREY PEREJON ROBERTO JAVIER. Datos registrales. T 1527 , F 122, S 8, H TO 2989, I/A 44 (27.10.11).

07/09/2011 Sec. I Revocaciones Toledo
Toledo-364626

Revocaciones — 07/09/2011

Revocaciones. Apo.Sol.: PORRAS RUIZ JOSE ANTONIO;GUTIERREZ TORIBIO DAVID. Apoderado: JIMENEZ GIL HELIODORA. Datos registrales. T 1510 , F 69, S 8, H TO 2989, I/A 40 (25.08.11).

07/09/2011 Sec. I Revocaciones Toledo
Toledo-364627

Revocaciones — 07/09/2011

Revocaciones. Apoderado: DIZ AREN JAIME. Nombramientos. Apoderado: LOPEZ RODRIGUEZ MARIA ROCIO. Datos registrales. T 1510 , F 69, S 8, H TO 2989, I/A 41 (25.08.11).

18/07/2011 Sec. I Revocaciones Toledo
Toledo-300988

Revocaciones — 18/07/2011

Revocaciones. Apo.Manc.: NARRILLOS ROUX MARIA ESTEFANIA;ALONSO ALONSO MERCEDES;BENITO ROLDAN MAGDALENA;MARTINEZ GONZALEZ FERNANDO;HIERRO SUREDA LUIS;PEREYRA LUIS DANIEL;GIL LOPEZ FERNANDO;SANTAMARIA PASCUAL JON JACOBO;M...

10/02/2011 Sec. I Nombramientos Toledo
Toledo-61239

Nombramientos — 10/02/2011

Nombramientos. Apoderado: VILLEGAS BALLESTEROS ALAIN. Datos registrales. T 1510 , F 68, S 8, H TO 2989, I/A 38 (31.01.11).

22/12/2010 Sec. I Nombramientos Toledo
Toledo-470807

Nombramientos — 22/12/2010

Nombramientos. Apoderado: ORTEGA ORTEGA JESUS. Datos registrales. T 1488 , F 63, S 8, H TO 2989, I/A 29 (13.12.10).

22/12/2010 Sec. I Nombramientos Toledo
Toledo-470808

Nombramientos — 22/12/2010

Nombramientos. Apoderado: CANAL MOSQUEIRA YOLANDA MERCEDES. Datos registrales. T 1488 , F 63, S 8, H TO 2989, I/A 30 (13.12.10).

22/12/2010 Sec. I Nombramientos Toledo
Toledo-470809

Nombramientos — 22/12/2010

Nombramientos. Apo.Sol.: DALMAU DEL BARRIO MARIA JOSE;DEL POZO VEGA DARIO. Datos registrales. T 1510 , F 66, S 8, H TO 2989, I/A 32 (13.12.10).