Actos destacados
Reducción de capital — 07/03/2017
Reducción de capital. Importe reducción: 105.120,00 Euros. Resultante Suscrito: 254.880,00 Euros. Ampliación de capital. Capital: 105.120,30 Euros. Resultante Suscrito: 360.000,30 Euros. Datos registrales. T 1494 , F 18...
Nombramientos — 20/09/2016
Nombramientos. Apoderado: PLACER MORILLO PARIS. Datos registrales. T 1494 , F 184, S 8, H VA 23551, I/A 8 (13.09.16).
Cambio de domicilio social — 20/09/2016
Cambio de domicilio social. C/ ACERA DE RECOLETOS 16 BAJO (VALLADOLID). Datos registrales. T 1494 , F 184, S 8, H VA 23551, I/A 9 (13.09.16). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 180 Martes 20 de septiembre de 20...
Nombramientos — 29/06/2016
Nombramientos. Apoderado: CANO JAUREGUI JORGE. Datos registrales. T 1494 , F 184, S 8, H VA 23551, I/A 7 (22.06.16).
Ceses/dimisiones — 28/04/2016
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ALONSO HERNANDEZ HIGINIO. Revocaciones. Apoderado: BUSTOS GARCIA SILVANO. Nombramientos. Consejero: DIAZ DE OLARTE VICARIO ALBERTO;RODRIGUEZ MARTINEZ SERGIO;GARCIA ARNAL RUBEN;URRUTIA RUIZ...
Nombramientos — 28/04/2016
Nombramientos. Apoderado: DIAZ DE OLARTE VICARIO ALBERTO. Datos registrales. T 1388 , F 4, S 8, H VA 23551, I/A 5 (21.04.16).
Revocaciones — 28/04/2016
Revocaciones. Apoderado: TELEGESCU ROMULUS GEORGE. Nombramientos. Apoderado: TELEGESCU ROMULUS GEORGE. Datos registrales. T 1494 , F 183, S 8, H VA 23551, I/A 6 (21.04.16). http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO...
Nombramientos — 22/03/2016
Nombramientos. Apoderado: TELEGESCU ROMULUS GEORGE. Datos registrales. T 1388 , F 3, S 8, H VA 23551, I/A 3 (15.03.16).
Nombramientos — 09/05/2011
Nombramientos. Apoderado: BUSTOS GARCIA SILVANO. Datos registrales. T 1388 , F 3, S 8, H VA 23551, I/A 2 (27.04.11).
Constitución — 25/11/2010
Constitución. Comienzo de operaciones: 28.10.10. Objeto social: La explotación de hoteles, restaurantes, bares, cafeterías, discotecas y establecimientos semejantes. La promoción, construcción, compra, venta, arrendamie...