Actos destacados
Otros conceptos: por oficio de fecha 21/01/2016, remitido por el jefe de servicio de administracion de justicia y registros de la junta de extremadura, la entidad de esta hoja se ha transformado en fundacion de caracter especial, quedando por tanto cerrada su hoja registral en esta oficina — 09/02/2016
Otros conceptos: POR OFICIO DE FECHA 21/01/2016, REMITIDO POR EL JEFE DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y REGISTROS DE LA JUNTA DE EXTREMADURA, LA ENTIDAD DE ESTA HOJA SE HA TRANSFORMADO EN FUNDACION DE CARACTER...
Nombramientos — 09/05/2013
Nombramientos. Apoderado: JIMENEZ LABRADOR EMILIO. Datos registrales. T 410 , F 204, S 8, H BA 1853, I/A 710 ( 2.05.13). http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Modificaciones estatutarias — 12/11/2012
Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 2. Domicilio.-. Otros conceptos: SE MODIFICA LA DISPOSICION TRANSITORIA CUARTA 3 DE LOS VIGENTES ESTATUTOS SOCIALES, ASI COMO LA DISPOSICION TRANSITORIAPRIMERA DEL...
Ceses/dimisiones — 07/06/2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: GORDILLO VAQUERO ESTRELLA;RUIZ MARTINEZ MIGUEL;ANTUNEZ APOLO AGUEDA;ASTORGA GONZALEZ ALBERTO. Consj. Supl.: SANTIAGO LAVADO JOSE;HERNANDEZ MACIAS MARIA LUZ;ALBARRAN CUENDA LORENZO;GARCIA PIZ...
Otros conceptos: por la presente inscripcion se acuerda el cierre de las sucursales de: cordoba 3, guadalupe(caceres), almendralejo urbana 2 y badajoz urbana las vaguadas — 13/04/2012
Otros conceptos: POR LA PRESENTE INSCRIPCION SE ACUERDA EL CIERRE DE LAS SUCURSALES DE: CORDOBA 3, GUADALUPE(CACERES), ALMENDRALEJO URBANA 2 Y BADAJOZ URBANA LAS VAGUADAS. Datos registrales. T 410 , F 200, S 8, H BA 185...
Otros conceptos: se han adaptado los estatutos y el reglamento del procedimiento regulador del sistema de designacion de los organos de gobierno de la entidad al rd ley 11/2010 de 9 de julio de organo de gobierno y otros aspectos del regimen juridico de las cajas de ahorros, asi como a la ley 1/2011 de 31 de enero — 10/04/2012
Otros conceptos: SE HAN ADAPTADO LOS ESTATUTOS Y EL REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO REGULADOR DEL SISTEMA DE DESIGNACION DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO DE LA ENTIDAD AL RD LEY 11/2010 DE 9 DE JULIO DE ORGANO DE GOBIERNO Y OTRO...
Escisión parcial — 10/01/2012
Escisión parcial. Sociedades beneficiarias de la escisión: BANCO GRUPO CAJATRES S.A. Datos registrales. T 410 , F 179, S 8, H BA 1853, I/A 705 (29.12.11).
Adaptación de sociedad — 07/10/2011
Adaptación de sociedad. Datos registrales. T 410 , F 164, S 8, H BA 1853, I/A 704 (28.09.11).
Reelecciones — 13/09/2011
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG S.L. Datos registrales. T 410 , F 163, S 8, H BA 1853, I/A 703 ( 1.09.11).
Otros conceptos: queda rectificada la precedente inscripcion 701& de esta hoja en el sentido de que el apoderado don enrique francisco jaramillo alvarez tiene como domicilio el de paseo de san francisco 18 en badajoz — 17/08/2011
Otros conceptos: QUEDA RECTIFICADA LA PRECEDENTE INSCRIPCION 701& DE ESTA HOJA EN EL SENTIDO DE QUE EL APODERADO DON ENRIQUE FRANCISCO JARAMILLO ALVAREZ TIENE COMO DOMICILIO EL DE PASEO DE SAN FRANCISCO 18 EN BADAJOZ. D...
Nombramientos — 09/08/2011
Nombramientos. Apoderado: JARAMILLO ALVAREZ ENRIQUE FRANCISCO. Datos registrales. T 410 , F 162, S 8, H BA 1853, I/A 701 (29.07.11).
Revocaciones — 26/07/2011
Revocaciones. Apo.Manc.: OLANO ALTUBE ANTONIO. Apo.Man.Soli: OLANO ALTUBE ANTONIO. Datos registrales. T 410 , F 162, S 8, H BA 1853, I/A 700 (14.07.11).
Nombramientos — 14/07/2011
Nombramientos. Apoderado: VALLE MESA SARA. Datos registrales. T 410 , F 161, S 8, H BA 1853, I/A 699 ( 5.07.11).
Revocaciones — 20/06/2011
Revocaciones. Apo.Sol.: MERINO MAQUEDA JOSE LUIS;NAVARRO ABAD ROCIO;MARTOS LARA ALFREDO. Apoderado: BRUZON BARRERAS OSCAR. Apo.Sol.: CID QUINTANILLA FERNANDO. Datos registrales. T 410 , F 160, S 8, H BA 1853, I/A 698 (...
Nombramientos — 10/06/2011
Nombramientos. Apoderado: BABIO MANTIÑAN GUSTAVO. Datos registrales. T 410 , F 159, S 8, H BA 1853, I/A 697 ( 1.06.11).
Otros conceptos: se declara el cierre de las siguientes sucursales: oficina de badajoz, urbana santa isabel; oficina de badajoz, urbana maria auxiliadora; oficina de merida, urbana luis chamizo; oficina de zafra, urbana 1 — 26/05/2011
Otros conceptos: SE DECLARA EL CIERRE DE LAS SIGUIENTES SUCURSALES: OFICINA DE BADAJOZ, URBANA SANTA ISABEL; OFICINA DE BADAJOZ, URBANA MARIA AUXILIADORA; OFICINA DE MERIDA, URBANA LUIS CHAMIZO; OFICINA DE ZAFRA, URBANA...
Nombramientos — 07/04/2011
Nombramientos. Apoderado: MAS DE XAXARS RUBIO JAVIER. Datos registrales. T 410 , F 157, S 8, H BA 1853, I/A 695 (29.03.11).
Nombramientos — 03/02/2011
Nombramientos. Apoderado: ESPINOSA FRANCO JOSE ANGEL. Datos registrales. T 410 , F 156, S 8, H BA 1853, I/A 694 (25.01.11).
Nombramientos — 11/11/2010
Nombramientos. Apoderado: ASENSIO QUILES JULIAN JOSE. Datos registrales. T 410 , F 154, S 8, H BA 1853, I/A 693 (29.10.10).
Revocaciones — 10/11/2010
Revocaciones. Apo.Sol.: MOROTE JIMENEZ ANTONIO;PEREZ ORREGO MARIA LUISA. Apoderado: MAYORAL CASILLAS AGUSTINA. Datos registrales. T 410 , F 154, S 8, H BA 1853, I/A 692 (28.10.10). http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL...
Otros conceptos: se decreta el cierre de la sucursal abierta en badajoz, avenida ricardo carapeto numero 130 c — 29/07/2010
Otros conceptos: SE DECRETA EL CIERRE DE LA SUCURSAL ABIERTA EN BADAJOZ, AVENIDA RICARDO CARAPETO NUMERO 130 C.P. 06008. Datos registrales. T 410 , F 154, S 8, H BA 1853, I/A 691 (20.07.10).
Revocaciones — 20/07/2010
Revocaciones. Apoderado: LEDESMA HERNANDEZ ROBERTO. Apo.Sol.: GONZALEZ MORENO ANTONIO;TORRES BENAVENTE JOSE MANUEL;ACEITON DELGADO RUFINO. Datos registrales. T 410 , F 154, S 8, H BA 1853, I/A 690 ( 9.07.10).
Revocaciones — 09/06/2010
Revocaciones. Apo.Sol.: GONZALEZ CHACON CARLOS ALFONSO;MELLADO GONZALEZ MARIA DEL CARMEN;DAVILA NIETO GUERRERO RAMON. Apoderado: RUFACO MAYORGA MARIA ISABEL. Datos registrales. T 410 , F 152, S 8, H BA 1853, I/A 688 (28...
Nombramientos — 09/06/2010
Nombramientos. Apoderado: RAMOS PRIETO ANTONIO. Datos registrales. T 410 , F 152, S 8, H BA 1853, I/A 689 (28.05.10).