Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2015 10 tarjetas
30/12/2015 Sec. I Otros conceptos: CANCELADOS LOS ASIENTOS DE LA SOCIEDAD Y CERRADA SU HOJA REGISTRAL Madrid
Madrid-529694

Otros conceptos: cancelados los asientos de la sociedad y cerrada su hoja registral — 30/12/2015

Otros conceptos: CANCELADOS LOS ASIENTOS DE LA SOCIEDAD Y CERRADA SU HOJA REGISTRAL. Datos registrales. T 33232 , F 205, S 8, H M 598051, I/A 11 (18.12.15).

20/11/2015 Sec. I Otros conceptos: CIERRE PROVISIONAL de la hoja de la Sociedad POR PLAZO DE SEIS MESES, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 231 RRM Madrid
Madrid-470652

Otros conceptos: cierre provisional de la hoja de la sociedad por plazo de seis meses, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 231 rrm — 20/11/2015

Otros conceptos: CIERRE PROVISIONAL de la hoja de la Sociedad POR PLAZO DE SEIS MESES, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 231 RRM.- Datos registrales. T 33232 , F 204, S 8, H M 598051, I/A 10-M (12.11.15).

25/08/2015 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-350724

Ceses/dimisiones — 25/08/2015

Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: MONDELEZ ESPAÑA COMMERCIAL SL. Representan: SAIZ RAMIREZ JOSE LUIS. Nombramientos. Adm. Solid.: MITJAVILA MOIX XAVIER;TORRENT BERNADAS DAVID. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administr...

25/08/2015 Sec. I Sociedad unipersonal Madrid
Madrid-350725

Sociedad unipersonal — 25/08/2015

Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: CHARGER OPCO BV. Datos registrales. T 33232 , F 202, S 8, H M 598051, I/A 8 (17.08.15).

25/08/2015 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-350726

Nombramientos — 25/08/2015

Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ COMELLA IGNACIO. Datos registrales. T 33232 , F 203, S 8, H M 598051, I/A 9 (17.08.15).

22/07/2015 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-303221

Revocaciones — 22/07/2015

Revocaciones. Apo.Manc.: MONTERO FERRERAS OSCAR;GARCIA SANDOVAL IGNACIO;CASTILLO CAMPO JESUS;PEÑA HORTAL CARLOS;MARCHAN GARCIA-PARDO PILAR;APARICIO SAINZ PALOMA;CASAÑO MARTINEZ PEDRO;IGLESIAS RAMOS JAVIER. Apo.Sol.: CAS...

17/03/2015 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-113879

Nombramientos — 17/03/2015

Nombramientos. Apo.Manc.: MONTERO FERRERAS OSCAR;GARCIA SANDOVAL IGNACIO;CASTILLO CAMPO JESUS;PEÑA HORTAL CARLOS;MARCHAN GARCIA-PARDO PILAR;APARICIO SAINZ PALOMA;CASAÑO MARTINEZ PEDRO;IGLESIAS RAMOS JAVIER. Datos regist...

17/03/2015 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-113880

Nombramientos — 17/03/2015

Nombramientos. Apo.Sol.: CASAÑO MARTINEZ PEDRO;IGLESIAS RAMOS JAVIER;PAYO CALDERON ANA BELEN;LOPEZ GIL FERNANDO;RIOS PEREZ FERNANDO. Datos registrales. T 33232 , F 65, S 8, H M 598051, I/A 3 ( 5.03.15).

17/03/2015 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-113881

Nombramientos — 17/03/2015

Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARCHAN GARCIA-PARDO PILAR;APARICIO SAINZ PALOMA;MONTERO FERRERAS OSCAR;GARCIA SANDOVAL IGNACIO;PEÑA HORTAL CARLOS;CASAÑO MARTINEZ PEDRO;IGLESIAS RAMOS JAVIER;LOPEZ GIL FERNANDO;RIOS PEREZ F...

13/03/2015 Sec. I Constitución Madrid
Madrid-109832

Constitución — 13/03/2015

Constitución. Comienzo de operaciones: 9.02.15. Objeto social: LA DISTRIBUCION, FABRICACION Y VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE TODA CLASE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ASI COMO LA DISTRIBUCION, VENTA Y EXPLOTACION DE MAQUINAS...