Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2019 5 tarjetas
23/04/2019 Sec. I Reducción de capital Toledo
Toledo-178811

Reducción de capital — 23/04/2019

Reducción de capital. Importe reducción: 30.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 416.000,00 Euros. Datos registrales. T 1316 , F 94, S 8, H TO 23786, I/A 8 (11.04.19).

16/11/2018 Sec. I Reelecciones Toledo
Toledo-459071

Reelecciones — 16/11/2018

Reelecciones. Consejero: TORRES PERALES FRANCISCO;PEREZ PRIVADO JESUS;PEREZAGUA FERNANDEZ JESUS;ARANDA PRISUELOS ANGEL;MARIN LOPEZ FRANCISCO;FERNANDEZ TORRES FRANCISCO;ALMENDROS RODELGO JOSE ANTONIO;DURANGO MARTIN JUAN...

16/06/2016 Sec. I Reducción de capital Toledo
Toledo-255443

Reducción de capital — 16/06/2016

Reducción de capital. Importe reducción: 36.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 446.000,00 Euros. Datos registrales. T 1316 , F 94, S 8, H TO 23786, I/A 6 ( 9.06.16).

15/01/2014 Sec. I Reelecciones Toledo
Toledo-16271

Reelecciones — 15/01/2014

Reelecciones. Consejero: TORRES PERALES FRANCISCO;PEREZ PRIVADO JESUS;PEREZAGUA FERNANDEZ JESUS;ARANDA PRISUELOS ANGEL;MARIN LOPEZ FRANCISCO;FERNANDEZ TORRES FRANCISCO;ALMENDROS RODELGO JOSE ANTONIO. Presidente: PEREZ P...

22/03/2011 Sec. I Reducción de capital Toledo
Toledo-129249

Reducción de capital — 22/03/2011

Reducción de capital. Importe reducción: 18.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 482.000,00 Euros. Datos registrales. T 1316 , F 93, S 8, H TO 23786, I/A 4 (10.03.11).