Actos destacados
Ceses/dimisiones — 02/02/2016
Ceses/Dimisiones. Liquidador: SANSO RIPOLL ANTONIO. Consejero: LLOMPART GELABERT ANTONIO;SANSO RIPOLL ANTONIO;LLULL SEGUI BERNARDO;LLULL BIBILONI BERNARDO;RIPOLL BAUZA JAIME. Cons.Del.Man: LLOMPART GELABERT ANTONIO. Sec...
Reducción de capital — 27/10/2015
Reducción de capital. Importe reducción: 180.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 64.800,00 Euros. Datos registrales. T 2293 , F 154, S 8, H PM 59414, I/A 5 (21.10.15). http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCA...
Reducción de capital — 10/06/2015
Reducción de capital. Importe reducción: 355.200,00 Euros. Resultante Suscrito: 244.800,00 Euros. Datos registrales. T 2293 , F 153, S 8, H PM 59414, I/A 4 (29.05.15).
Nombramientos — 23/09/2013
Nombramientos. Consejero: LLOMPART GELABERT ANTONIO. Presidente: LLULL SEGUI BERNARDO. Cons.Del.Man: LLOMPART GELABERT ANTONIO. Reelecciones. Secretario: SANSO RIPOLL ANTONIO. Cons.Del.Man: RIPOLL BAUZA JAIME;SANSO RIPO...
Ceses/dimisiones — 28/11/2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: CATALA SALAS BARTOLOME. Presidente: CATALA SALAS BARTOLOME. Cons.Del.Man: CATALA SALAS BARTOLOME. Datos registrales. T 2293 , F 153, S 8, H PM 59414, I/A 2 (19.11.12).