Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2018 5 tarjetas
09/10/2018 Sec. I Cierre provisional hoja registral por baja en el índice de Entidades Jurídicas Córdoba
Córdoba-405029

Cierre provisional hoja registral por baja en el índice de entidades jurídicas — 09/10/2018

Cierre provisional hoja registral por baja en el índice de Entidades Jurídicas. Datos registrales. T 1714 , F 13, S 8, H CO 20115, I/A 1 H ( 1.10.18).

13/05/2013 Sec. I Ceses/Dimisiones Córdoba
Córdoba-218030

Ceses/dimisiones — 13/05/2013

Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: SERRANO MORENO MARIA DOLORES. Datos registrales. T 1714 , F 21, S 8, H CO 20115, I/A 12 ( 6.05.13).

11/11/2009 Sec. I Ceses/Dimisiones Córdoba
Córdoba-469907

Ceses/dimisiones — 11/11/2009

Ceses/Dimisiones. Consejero: GOMEZ SANCHEZ RAFAEL. Presidente: GOMEZ SANCHEZ RAFAEL. Cons.Del.Sol: GOMEZ SANCHEZ RAFAEL. Consejero: GOMEZ SERRANO ESTHER. Secretario: GOMEZ SERRANO ESTHER. Cons.Del.Sol: GOMEZ SERRANO EST...

11/11/2009 Sec. I Nombramientos Córdoba
Córdoba-469908

Nombramientos — 11/11/2009

Nombramientos. Apo.Man.Soli: GOMEZ SERRANO RAFAEL JOSE;GOMEZ SERRANO JOSE MARIA;GOMEZ SERRANO MANUEL;GOMEZ SERRANO ESTHER. Datos registrales. T 1714 , F 20, S 8, H CO 20115, I/A 10 (30.10.09).

11/11/2009 Sec. I Revocaciones Córdoba
Córdoba-469909

Revocaciones — 11/11/2009

Revocaciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Nombramientos. Auditor: MORAL Y SILOS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 1714 , F 20, S 8, H CO 20115, I/A 11 (30.10.09).