Actos destacados
Ceses/dimisiones — 24/12/2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: CAMI CASELLAS IGNASI;AVILA RIVERO SILVIA. Presidente: LORENZO MURADAS FRANCISCO JAVIER. Consejero: LORENZO MURADAS FRANCISCO JAVIER;LOPEZ ZABALLOS JULIAN. Vicepresid.: CAMI CASELLAS IGNASI....
Otros conceptos: cesión de la cartera de pólizas de seguros integrantes del ramo de enfermedad, comprendida la asistencia sanitaria, de la sociedad de esta hoja a favor de "caja de seguros reunidos compaÑia de seguros y reaseguros sa" — 18/11/2015
Otros conceptos: Cesión de la cartera de pólizas de seguros integrantes del ramo de enfermedad, comprendida la asistencia sanitaria, de la Sociedad de esta hoja a favor de "CAJA DE SEGUROS REUNIDOS COMPAÑIA DE SEGUROS Y...
Otros conceptos: cesión parcial de cartera por parte de "caja de seguros reunidos, compañía de seguros y reaseguros sa" a la mercantil "mediterraneo seguros diversos, compaÑia de seguros y reaseguros sa" — 18/03/2015
Otros conceptos: Cesión parcial de cartera por parte de "Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros SA" a la Mercantil "MEDITERRANEO SEGUROS DIVERSOS, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA". Datos registra...
Nombramientos — 24/12/2014
Nombramientos. Apoderado: TORRES TORMO MATEU. Datos registrales. T 3817 , F 180, S 8, H A 102789, I/A 34 (17.12.14).
Nombramientos — 24/12/2014
Nombramientos. Apoderado: MATEU SATUE BRUNO. Apo.Manc.: MATEU SATUE BRUNO. Datos registrales. T 3817 , F 180, S 8, H A 102789, I/A 35 (17.12.14).
Nombramientos — 23/12/2014
Nombramientos. Apoderado: GABARRO OLIVET MARGARIDA. Apo.Manc.: GABARRO OLIVET MARGARIDA. Datos registrales. T 3817 , F 179, S 8, H A 102789, I/A 33 (16.12.14).
Nombramientos — 22/12/2014
Nombramientos. Apoderado: AGUIRRE JIMENEZ TOMAS. Datos registrales. T 3817 , F 179, S 8, H A 102789, I/A 32 (15.12.14).
Nombramientos — 18/12/2014
Nombramientos. Apo.Sol.: VALLE T-FIGUERAS FRANCISCO JAVIER. Apo.Manc.: VALLE T-FIGUERAS FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 3817 , F 178, S 8, H A 102789, I/A 31 (11.12.14). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm...
Revocaciones — 15/12/2014
Revocaciones. Apoderado: CAMPOS GUITART ANTONIO. Datos registrales. T 3817 , F 178, S 8, H A 102789, I/A 30 ( 5.12.14).
Otros conceptos: artículo 20º — 10/12/2014
Otros conceptos: Artículo 20º. Del Organo de Administración. Datos registrales. T 3575 , F 216, S 8, H A 102789, I/A 29 ( 2.12.14).
Declaración de unipersonalidad — 09/12/2014
Declaración de unipersonalidad. Socio único: BANSABADELL SEGUROS GENERALES SA DE SEGUROS Y REAS. Datos registrales. T 3575 , F 215, S 8, H A 102789, I/A 27 ( 1.12.14).
Ceses/dimisiones — 09/12/2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: CAMPOS GUITART ANTONIO;RODRIGUEZ CASTILLO FEDERICO. Presidente: CAMI CASELLAS IGNASI. SecreNoConsj: MORENO LLORENS INMACULADA. Nombramientos. SecreNoConsj: BAS SHORT CARLOS. VsecrNoConsj: DE...
Reelecciones — 31/10/2014
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 3575 , F 215, S 8, H A 102789, I/A 26 (23.10.14).
Nombramientos — 29/08/2014
Nombramientos. Apoderado: CAMPOS GUITART ANTONIO. Datos registrales. T 3575 , F 215, S 8, H A 102789, I/A 25 (21.08.14).
Revocaciones — 26/08/2014
Revocaciones. Apoderado: MEDINA BUENO SEBASTIAN MIGUEL. Datos registrales. T 3575 , F 215, S 8, H A 102789, I/A 24 (19.08.14).
Cambio de domicilio social — 21/08/2014
Cambio de domicilio social. AVDA OSCAR ESPLA 37 (ALICANTE). Datos registrales. T 3575 , F 59, S 8, H A 102789, I/A 22 (12.08.14).
Ceses/dimisiones — 24/12/2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: TRESANCHEZ MONTANER MANUEL;PALAVECINO TOME SERGIO ALEJANDRO. Nombramientos. Consejero: AVILA RIVERO SILVIA;CAMPOS GUITART ANTONIO. Datos registrales. T 3575 , F 59, S 8, H A 102789, I/A 21 (...
Reelecciones — 02/09/2013
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 3575 , F 59, S 8, H A 102789, I/A 20 (23.08.13).
Revocaciones — 23/07/2013
Revocaciones. Apoderado: DAVO MUNTO JUAN;MEDINA BUENO SEBASTIAN MIGUEL. Apo.Man.Soli: MEDINA BUENO SEBASTIAN MIGUEL. Apo.Manc.: EYRIES GARCIA DE VINUESA IGNACIO;GIRONELLA GARCIA JUAN MANUEL;DIEZ BOLETÍN OFICIAL DEL REGI...
Ceses/dimisiones — 06/11/2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: GALIANO ARACIL FRANCISCO;ABAD ESTEVE JAVIER;GONSALBEZ FABRA MARIA DOLORES NELLY;GOMEZ GOMEZ JUAN JESUS. Secretario: GOMEZ GOMEZ JUAN JESUS. Nombramientos. SecreNoConsj: MORENO LLORENS INMACU...
Ampliación de capital — 18/01/2012
Ampliación de capital. Suscrito: 1.600.000,00 Euros. Desembolsado: 1.600.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 11.600.000,00 Euros. Resultante Desembolsado: 11.600.000,00 Euros. Datos registrales. T 3575 , F 57, S 8, H A 1...
Nombramientos — 16/12/2011
Nombramientos. Apo.Manc.: PUCHE PAJARES DANIEL;BRU CASTRO CONCEPCION;ZORITA GONZALEZ CONSUELO;COSTALES ARTIEDA JUAN RAMON;GARCIA LOPEZ FRANCISCO JAVIER;GARCIA FERNANDEZ ANGEL LUIS. Datos registrales. T 3477 , F 70, S 8,...
Cambio de domicilio social — 18/11/2011
Cambio de domicilio social. C/ ARZOBISPO LOACES 3 7& (ALICANTE). Datos registrales. T 3477 , F 70, S 8, H A 102789, I/A 13 ( 8.11.11).
Nombramientos — 11/10/2011
Nombramientos. Apo.Sol.: GONZALEZ PISON CARLOS RAMON;BERMEJO ALBARES ILDEFONSO;SUAREZ REQUENA HECTOR LUIS;REVILLA CASTRO BEATRIZ. Datos registrales. T 3477 , F 70, S 8, H A 102789, I/A 12 (29.09.11).