Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2025 17 tarjetas
31/12/2025 Sec. I Nombramientos Pontevedra
Pontevedra-587143

Nombramientos — 31/12/2025

Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ GARCIA ALVARO. Datos registrales. S 8 , H PO 34135, I/A 45 (23.12.25). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 249 Miércoles 31 de diciembre de 2025 Pág. 61219 cve: BORME-A-2025-24...

31/12/2025 Sec. I Nombramientos Pontevedra
Pontevedra-587144

Nombramientos — 31/12/2025

Nombramientos. Apoderado: PARDAVILA MARTINEZ VICTOR. Datos registrales. S 8 , H PO 34135, I/A 46 (23.12.25).

25/11/2019 Sec. I Ceses/Dimisiones Pontevedra
Pontevedra-486119

Ceses/dimisiones — 25/11/2019

Ceses/Dimisiones. Consejero: KJELGAARD TOMAS BRIX. Nombramientos. Consejero: RODRIGUEZ RANCAÑO GONZALO. Datos registrales. T 2917, L 2917, F 91, S 8, H PO 34135, I/A 41 (15.11.19).

13/09/2019 Sec. I Nombramientos Pontevedra
Pontevedra-390853

Nombramientos — 13/09/2019

Nombramientos. Auditor: K4 IBERICA AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL. Datos registrales. T 2917, L 2917, F 91, S 8, H PO 34135, I/A 40 ( 4.09.19).

27/10/2016 Sec. I Ceses/Dimisiones Pontevedra
Pontevedra-435292

Ceses/dimisiones — 27/10/2016

Ceses/Dimisiones. Consejero: LLOVES VIEIRA JULIO. Cons.Del.Sol: LLOVES VIEIRA JULIO. Nombramientos. Consejero: CASTRO CELTA SL. Apo.Sol.: PARDAVILA MARTINEZ VICTOR;APARICIO GONZALEZ MARIA TERESA;RANCAÑO RODRIGUEZ GONZAL...

21/10/2016 Sec. I Nombramientos Pontevedra
Pontevedra-425518

Nombramientos — 21/10/2016

Nombramientos. Aud.Supl.: CARBALLO FIDALGO PILAR. Reelecciones. Auditor: DE LA TORRE NIETO GERMAN. Datos registrales. T 2917, L 2917, F 89, S 8, H PO 34135, I/A 37 (14.10.16).

29/02/2016 Sec. I Nombramientos Pontevedra
Pontevedra-91806

Nombramientos — 29/02/2016

Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ GARCIA ALVARO. Datos registrales. T 2917, L 2917, F 89, S 8, H PO 34135, I/A 36 (17.02.16).

02/09/2015 Sec. I Modificaciones estatutarias Pontevedra
Pontevedra-359990

Modificaciones estatutarias — 02/09/2015

Modificaciones estatutarias. Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/12. Datos registrales. T 2917, L 2917, F 89, S 8, H PO 34135, I/A 35 (25.08.15).

20/12/2013 Sec. I Ceses/Dimisiones Pontevedra
Pontevedra-545264

Ceses/dimisiones — 20/12/2013

Ceses/Dimisiones. Consejero: PEDERSEN CHRESTEN. Cancelaciones de oficio de nombramientos. Auditor: CARBALLO FIDALGO MARIA PILAR. Aud.Supl.: GODOY VAZQUEZ MARTA. Nombramientos. Consejero: KJELGAARD TOMAS BRIX. Auditor: D...

02/11/2012 Sec. I Revocaciones Pontevedra
Pontevedra-450404

Revocaciones — 02/11/2012

Revocaciones. Con.Delegado: LLOVES VIEIRA JULIO. Nombramientos. Cons.Del.Sol: LLOVES VIEIRA PABLO;LLOVES VIEIRA JULIO. Reelecciones. Consejero: LLOVES VIEIRA JULIO;LLOVES VIEIRA PABLO;PEDERSEN CHRESTEN. Presidente: LLOV...

17/05/2012 Sec. I Reelecciones Pontevedra
Pontevedra-209072

Reelecciones — 17/05/2012

Reelecciones. Auditor: CARBALLO FIDALGO MARIA PILAR. Aud.Supl.: GODOY VAZQUEZ MARTA. Datos registrales. T 2917, L 2917, F 87, S 8, H PO 34135, I/A 30 ( 4.05.12).

17/02/2011 Sec. I Fe de erratas: A medio de escritura otorgada el día 12 de enero de 2011 por el Notario deVigo don Antonio A Pontevedra
Pontevedra-73037

Fe de erratas: a medio de escritura otorgada el día 12 de enero de 2011 por el notario devigo don antonio a — 17/02/2011

Fe de erratas: A medio de escritura otorgada el día 12 de enero de 2011 por el Notario deVigo don Antonio A. Salgueiro Armada, número 32 de protocolo, se rectifican los apellidos del apoderado que figura en la inscripci...

18/11/2010 Sec. I Revocaciones Pontevedra
Pontevedra-426312

Revocaciones — 18/11/2010

Revocaciones. Apo.Manc.: APARICIO GONZALEZ MARIA TERESA;RODRIGUEZ RANCAÑO GONZALO. Nombramientos. Apo.Man.Soli: APARICIO GONZALEZ MARIA TERESA;RODRIGUEZ RANCAÑO GONZALO. Datos registrales. T 2917, L 2917, F 87, S 8, H P...

22/07/2010 Sec. I Revocaciones Pontevedra
Pontevedra-289271

Revocaciones — 22/07/2010

Revocaciones. Apo.Manc.: KJAERSGAARD ANDERS. Nombramientos. Apo.Manc.: APARICIO GONZALEZ MARIA TERESA;RODRIGUEZ RANCAÑO GONZALO. Datos registrales. T 2917, L 2917, F 87, S 8, H PO 34135, I/A 27 (12.07.10).

22/06/2009 Sec. I Declaración de unipersonalidad Pontevedra
Pontevedra-280806

Declaración de unipersonalidad — 22/06/2009

Declaración de unipersonalidad. Socio único: MASCATO SL. Ceses/Dimisiones. Consejero: LLOVES VIEIRA EDUARDO. Nombramientos. Consejero: PEDERSEN CHRESTEN. Datos registrales. T 2917, L 2917, F 19, S 8, H PO 34135, I/A 26...

28/04/2009 Sec. I Nombramientos Pontevedra
Pontevedra-198683

Nombramientos — 28/04/2009

Nombramientos. Apo.Manc.: PARDAVILA MARTINEZ VICTOR;KJAERSGAARD ANDERS. Datos registrales. T 2917, L 2917, F 19, S 8, H PO 34135, I/A 25 (16.04.09).

13/03/2009 Sec. I Revocaciones Pontevedra
Pontevedra-129872

Revocaciones — 13/03/2009

Revocaciones. Apo.Man.Soli: MANTECON RODRIGUEZ GERMAN EDUARDO. Apoderado: MANTECON RODRIGUEZ GERMAN EDUARDO. Nombramientos. Con.Delegado: LLOVES VIEIRA JULIO. Apoderado: PARDAVILA MARTINEZ VICTOR. Datos registrales. T 2...