Actos destacados
Nombramientos — 31/12/2025
Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ GARCIA ALVARO. Datos registrales. S 8 , H PO 34135, I/A 45 (23.12.25). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 249 Miércoles 31 de diciembre de 2025 Pág. 61219 cve: BORME-A-2025-24...
Nombramientos — 31/12/2025
Nombramientos. Apoderado: PARDAVILA MARTINEZ VICTOR. Datos registrales. S 8 , H PO 34135, I/A 46 (23.12.25).
Ceses/dimisiones — 25/11/2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: KJELGAARD TOMAS BRIX. Nombramientos. Consejero: RODRIGUEZ RANCAÑO GONZALO. Datos registrales. T 2917, L 2917, F 91, S 8, H PO 34135, I/A 41 (15.11.19).
Nombramientos — 13/09/2019
Nombramientos. Auditor: K4 IBERICA AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL. Datos registrales. T 2917, L 2917, F 91, S 8, H PO 34135, I/A 40 ( 4.09.19).
Ceses/dimisiones — 27/10/2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: LLOVES VIEIRA JULIO. Cons.Del.Sol: LLOVES VIEIRA JULIO. Nombramientos. Consejero: CASTRO CELTA SL. Apo.Sol.: PARDAVILA MARTINEZ VICTOR;APARICIO GONZALEZ MARIA TERESA;RANCAÑO RODRIGUEZ GONZAL...
Nombramientos — 21/10/2016
Nombramientos. Aud.Supl.: CARBALLO FIDALGO PILAR. Reelecciones. Auditor: DE LA TORRE NIETO GERMAN. Datos registrales. T 2917, L 2917, F 89, S 8, H PO 34135, I/A 37 (14.10.16).
Nombramientos — 29/02/2016
Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ GARCIA ALVARO. Datos registrales. T 2917, L 2917, F 89, S 8, H PO 34135, I/A 36 (17.02.16).
Modificaciones estatutarias — 02/09/2015
Modificaciones estatutarias. Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/12. Datos registrales. T 2917, L 2917, F 89, S 8, H PO 34135, I/A 35 (25.08.15).
Ceses/dimisiones — 20/12/2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: PEDERSEN CHRESTEN. Cancelaciones de oficio de nombramientos. Auditor: CARBALLO FIDALGO MARIA PILAR. Aud.Supl.: GODOY VAZQUEZ MARTA. Nombramientos. Consejero: KJELGAARD TOMAS BRIX. Auditor: D...
Revocaciones — 02/11/2012
Revocaciones. Con.Delegado: LLOVES VIEIRA JULIO. Nombramientos. Cons.Del.Sol: LLOVES VIEIRA PABLO;LLOVES VIEIRA JULIO. Reelecciones. Consejero: LLOVES VIEIRA JULIO;LLOVES VIEIRA PABLO;PEDERSEN CHRESTEN. Presidente: LLOV...
Reelecciones — 17/05/2012
Reelecciones. Auditor: CARBALLO FIDALGO MARIA PILAR. Aud.Supl.: GODOY VAZQUEZ MARTA. Datos registrales. T 2917, L 2917, F 87, S 8, H PO 34135, I/A 30 ( 4.05.12).
Fe de erratas: a medio de escritura otorgada el día 12 de enero de 2011 por el notario devigo don antonio a — 17/02/2011
Fe de erratas: A medio de escritura otorgada el día 12 de enero de 2011 por el Notario deVigo don Antonio A. Salgueiro Armada, número 32 de protocolo, se rectifican los apellidos del apoderado que figura en la inscripci...
Revocaciones — 18/11/2010
Revocaciones. Apo.Manc.: APARICIO GONZALEZ MARIA TERESA;RODRIGUEZ RANCAÑO GONZALO. Nombramientos. Apo.Man.Soli: APARICIO GONZALEZ MARIA TERESA;RODRIGUEZ RANCAÑO GONZALO. Datos registrales. T 2917, L 2917, F 87, S 8, H P...
Revocaciones — 22/07/2010
Revocaciones. Apo.Manc.: KJAERSGAARD ANDERS. Nombramientos. Apo.Manc.: APARICIO GONZALEZ MARIA TERESA;RODRIGUEZ RANCAÑO GONZALO. Datos registrales. T 2917, L 2917, F 87, S 8, H PO 34135, I/A 27 (12.07.10).
Declaración de unipersonalidad — 22/06/2009
Declaración de unipersonalidad. Socio único: MASCATO SL. Ceses/Dimisiones. Consejero: LLOVES VIEIRA EDUARDO. Nombramientos. Consejero: PEDERSEN CHRESTEN. Datos registrales. T 2917, L 2917, F 19, S 8, H PO 34135, I/A 26...
Nombramientos — 28/04/2009
Nombramientos. Apo.Manc.: PARDAVILA MARTINEZ VICTOR;KJAERSGAARD ANDERS. Datos registrales. T 2917, L 2917, F 19, S 8, H PO 34135, I/A 25 (16.04.09).
Revocaciones — 13/03/2009
Revocaciones. Apo.Man.Soli: MANTECON RODRIGUEZ GERMAN EDUARDO. Apoderado: MANTECON RODRIGUEZ GERMAN EDUARDO. Nombramientos. Con.Delegado: LLOVES VIEIRA JULIO. Apoderado: PARDAVILA MARTINEZ VICTOR. Datos registrales. T 2...