Actos destacados
Disolución — 21/12/2017
Disolución. Fusion. Extinción. Datos registrales. T 32832 , F 161, S 8, H M 404717, I/A 80 (14.12.17).
Nombramientos — 04/12/2017
Nombramientos. Apoderado: RUIZ SERRANO DANIEL. Datos registrales. T 32832 , F 159, S 8, H M 404717, I/A 77 (24.11.17).
Nombramientos — 04/12/2017
Nombramientos. Apo.Man.Soli: MEDINA SANTAMARIA ARTURO. Datos registrales. T 32832 , F 159, S 8, H M 404717, I/A 78 (24.11.17).
Cambio de domicilio social — 18/05/2017
Cambio de domicilio social. AVDA DE LA VEGA 15 (ALCOBENDAS). Datos registrales. T 32832 , F 158, S 8, H M 404717, I/A 76 (10.05.17).
Nombramientos — 07/04/2017
Nombramientos. Apoderado: GUERRERO FERRER VICTOR. Datos registrales. T 32832 , F 156, S 8, H M 404717, I/A 74 (30.03.17).
Nombramientos — 24/02/2017
Nombramientos. Apoderado: MOLINA ZAMORA FERNANDO;SANTOS FERNANDEZ MIGUEL;SODERBERG OLOF URBAN. Datos registrales. T 32832 , F 145, S 8, H M 404717, I/A 65 (15.02.17).
Nombramientos — 24/02/2017
Nombramientos. Apoderado: LUQUE RUIZ DE MIER FRANCISCO JOSE. Datos registrales. T 32832 , F 146, S 8, H M 404717, I/A 66 (15.02.17). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 39 Viernes 24 de febrero de 2017 Pág. 9687...
Revocaciones — 24/02/2017
Revocaciones. Apo.Manc.: UTRILLA SAN VICENTE FELIPE. Apo.Man.Soli: RIVERA MATIAS MANUEL;MARIN DE LA PLAZA FRANCISCO JAVIER. Nombramientos. Apoderado: TAULET FERRANDO EDUARDO;SUAREZ GARCIA MIGUEL ANGEL;LOPEZ FERNANDEZ JO...
Revocaciones — 24/02/2017
Revocaciones. Apo.Sol.: DUARTE GARCIA ROBERTO. Datos registrales. T 32832 , F 150, S 8, H M 404717, I/A 68 (15.02.17).
Revocaciones — 24/02/2017
Revocaciones. Apoderado: DELGADO DOMINGUEZ JUAN LUIS;LOPEZ GRANADOS BELEN. Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ MUÑOZ PABLO;LOIS CIGARRAN PEDRO;LOPEZ GRANADOS BELEN;CARDONA ARRANZ BELEN;FREIRE BARRAL PABLO. Datos registra...
Nombramientos — 24/02/2017
Nombramientos. Apoderado: RIVERA MATIAS MANUEL;PASCUAL ZARATE PILAR. Datos registrales. T 32832 , F 152, S 8, H M 404717, I/A 70 (15.02.17).
Revocaciones — 24/02/2017
Revocaciones. Apoderado: RODRIGUEZ GONZALEZ ROBERTO;CUADROS ROCA JOSE MANUEL. Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ GONZALEZ ROBERTO;CUADROS ROCA JOSE MANUEL. Datos registrales. T 32832 , F 154, S 8, H M 404717, I/A 71 (1...
Nombramientos — 24/02/2017
Nombramientos. Apoderado: GARCIA SANCHEZ JESUS MARIA. Datos registrales. T 32832 , F 155, S 8, H M 404717, I/A 72 (15.02.17).
Sociedad unipersonal — 09/01/2017
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: XFERA MOVILES SA. Datos registrales. T 32832 , F 145, S 8, H M 404717, I/A 64 (28.12.16).
Modificaciones estatutarias — 21/12/2016
Modificaciones estatutarias. Se modifica el ARTICULO 10 y se incluye el ARTICULO 10 BIS, de los Estatutos.-. Datos registrales. T 32832 , F 144, S 8, H M 404717, I/A 63 (13.12.16).
Sociedad unipersonal — 27/10/2016
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: MASMOVIL HOLDPHONE SA. Datos registrales. T 32832 , F 143, S 8, H M 404717, I/A 62 (20.10.16).
Revocaciones — 31/03/2016
Revocaciones. Apo.Sol.: NAVARRO SOLER SUSANA. Datos registrales. T 32832 , F 141, S 8, H M 404717, I/A 59 (21.03.16).
Revocaciones — 29/03/2016
Revocaciones. Apoderado: SANCHEZ GARCIA ANGEL-MARIA. Datos registrales. T 32832 , F 141, S 8, H M 404717, I/A 58 (18.03.16).
Nombramientos — 09/04/2015
Nombramientos. Apoderado: BARROSO GONZALEZ OLGA MARIA. Datos registrales. T 32832 , F 135, S 8, H M 404717, I/A 47 (30.03.15).
Ceses/dimisiones — 23/07/2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: ECHARRI TORRES JOSEP MARIA;GARCIA ORTIZ ANTONIO;SOLLI NYBORG CHRISTIAN;ALDEBARAN RIESGO S.C.R. DE REGIMEN SIMPLIFICADO SA;ABAD RICO CARLOS FRANCISCO;DE MULLER BARBAT BORJA;DIEZ-HOCHLEITNER R...
Nombramientos — 23/07/2014
Nombramientos. Apoderado: CASTAÑEDA GONZALEZ ALBERTO. Datos registrales. T 32007 , F 26, S 8, H M 404717, I/A 35 (15.07.14). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 138 Miércoles 23 de julio de 2014 Pág. 33060 cve:...
Ampliación de capital — 12/05/2014
Ampliación de capital. Suscrito: 3.425,31 Euros. Desembolsado: 3.425,31 Euros. Resultante Suscrito: 235.909,39 Euros. Resultante Desembolsado: 235.909,39 Euros. Datos registrales. T 32007 , F 23, S 8, H M 404717, I/A 32...
Otros conceptos: rectificado error padecido en la redaccion del articulo 5 de los estatutos sociales en boletÍn oficial del registro mercantil núm — 11/04/2014
Otros conceptos: RECTIFICADO ERROR PADECIDO EN LA REDACCION DEL ARTICULO 5 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES EN BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 71 Viernes 11 de abril de 2014 Pág. 17580 cve: BORME-A-2014-71-28 LOS A...
MAS MOVIL TELECOM 3.0 SA
Nombramientos. CONSEJERO: CASALS ANDREU ROGER. Datos registrales. T 42449 , F 158, S 8, H B 408603, I/A 37 BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 182 Martes 24 de septiembre de 2013 Pág. 44189 cve: BORME-A-2013-182...