Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2019 24 tarjetas
11/04/2019 Sec. I Escisión total Madrid
Madrid-163516

Escisión total — 11/04/2019

Escisión total. Sociedades beneficiarias de la escisión: MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA. MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS SA. MAPFRE GLOBAL RISKS AGENCIA DE SUSCRIPCION SA. SERVIFINANZAS SA. Disolució...

14/02/2019 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-69572

Ceses/dimisiones — 14/02/2019

Ceses/Dimisiones. Consejero: BAEZA GOMEZ IGNACIO. MiemComDirec: BAEZA GOMEZ IGNACIO. PresComDirec: BAEZA GOMEZ IGNACIO. Consejero: GOMEZ CIRIA ANTONIO. MiemComDirec: GOMEZ CIRIA ANTONIO. Presidente: BAEZA GOMEZ IGNACIO....

19/10/2018 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-418711

Nombramientos — 19/10/2018

Nombramientos. Apoderado: LUC ALDON JEAN PIERRE. Datos registrales. T 34266 , F 123, S 8, H M 189128, I/A 383 ( 8.10.18).

21/06/2018 Sec. I Declaración de unipersonalidad Madrid
Madrid-261512

Declaración de unipersonalidad — 21/06/2018

Declaración de unipersonalidad. Socio único: MAPFRE SA. Datos registrales. T 34266 , F 121, S 8, H M 189128, I/A 381 (13.06.18).

12/04/2018 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-162287

Nombramientos — 12/04/2018

Nombramientos. MiemComDirec: GOMEZ CIRIA ANTONIO. Datos registrales. T 34266 , F 120, S 8, H M 189128, I/A 376 ( 4.04.18).

12/04/2018 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-162288

Revocaciones — 12/04/2018

Revocaciones. Apo.Sol.: GIRALDA PIÑEIRO SIRO. Datos registrales. T 34266 , F 120, S 8, H M 189128, I/A 377 ( 4.04.18).

14/02/2018 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-72775

Ceses/dimisiones — 14/02/2018

Ceses/Dimisiones. MiemComDirec: ALONSO BATRES ANGEL. Consejero: ALONSO BATRES ANGEL. Datos registrales. T 34266 , F 119, S 8, H M 189128, I/A 374 ( 6.02.18).

04/10/2017 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-392871

Revocaciones — 04/10/2017

Revocaciones. Apo.Sol.: IBAÑEZ GOTZENS JOSE LUIS. Apoderado: IBAÑEZ GOTZENS JOSE LUIS. Datos registrales. T 34266 , F 118, S 8, H M 189128, I/A 371 (27.09.17).

09/06/2017 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-240628

Revocaciones — 09/06/2017

Revocaciones. Apo.Man.Soli: BERGAMIN SERRANO FRANCISCO JAVIER;BERGAMIN SERRANO FRANCISCO JAVIER. Apo.Sol.: BERGAMIN SERRANO FRANCISCO JAVIER;CASTELO MARIN ALFREDO. Datos registrales. T 34266 , F 118, S 8, H M 189128, I/...

25/04/2017 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-177427

Revocaciones — 25/04/2017

Revocaciones. Apo.Sol.: PEREZ ALONSO ANTONIO JOSE;MARTINEZ MENDOZA FERRAN. Apo.Man.Soli: MANZANO MARTOS ALBERTO. Apo.Sol.: ORTIZ TRUJILLANO JACINTO. Apo.Man.Soli: ALMAZAN MANZANO MIGUEL ANGEL. Apo.Sol.: VIVAS GARCIA CAR...

14/02/2017 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-72271

Nombramientos — 14/02/2017

Nombramientos. MiemComDirec: FRANCOY OLAGUE JUAN BOSCO. Datos registrales. T 34266 , F 116, S 8, H M 189128, I/A 364 ( 6.02.17).

11/01/2017 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-12391

Nombramientos — 11/01/2017

Nombramientos. Apoderado: SANZ ISLA MARIA ELENA. Datos registrales. T 34266 , F 113, S 8, H M 189128, I/A 361 ( 2.01.17).

11/05/2016 Sec. I Pérdida del caracter de unipersonalidad Madrid
Madrid-203213

Pérdida del caracter de unipersonalidad — 11/05/2016

Pérdida del caracter de unipersonalidad. Datos registrales. T 34266 , F 109, S 8, H M 189128, I/A 355 ( 3.05.16). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 89 Miércoles 11 de mayo de 2016 Pág. 21845 cve: BORME-A-2016-...

08/03/2016 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-108061

Nombramientos — 08/03/2016

Nombramientos. Apoderado: SMITH CHRISTOPHER PAUL. Datos registrales. T 34266 , F 101, S 8, H M 189128, I/A 348 (26.02.16).

08/03/2016 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-108062

Nombramientos — 08/03/2016

Nombramientos. Apoderado: HARRYS GREGORY JOHN MONKMAN. Datos registrales. T 34266 , F 103, S 8, H M 189128, I/A 349 (26.02.16).

08/03/2016 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-108063

Nombramientos — 08/03/2016

Nombramientos. Apoderado: ALSDORF MANFRED. Datos registrales. T 34266 , F 104, S 8, H M 189128, I/A 350 (29.02.16).

08/03/2016 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-108064

Nombramientos — 08/03/2016

Nombramientos. Apoderado: HAQUETTE JEAN MARIE. Datos registrales. T 34266 , F 106, S 8, H M 189128, I/A 351 (29.02.16).

08/03/2016 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-108065

Nombramientos — 08/03/2016

Nombramientos. Consejero: INCHAUSTI PEREZ JOSE MANUEL. Datos registrales. T 34266 , F 108, S 8, H M 189128, I/A 352 (29.02.16).

18/02/2016 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-73421

Ceses/dimisiones — 18/02/2016

Ceses/Dimisiones. MiemComDirec: DE MACEDO COUTINHO DE ALMEIDA PEDRO JOSE. Datos registrales. T 28632 , F 163, S 8, H M 189128, I/A 346 (11.02.16).

09/02/2016 Sec. I Modificaciones estatutarias Madrid
Madrid-57417

Modificaciones estatutarias — 09/02/2016

Modificaciones estatutarias. Refundición de Estatutos sociales . Datos registrales. T 28632 , F 160, S 8, H M 189128, I/A 343 ( 1.02.16).

30/12/2015 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-529899

Nombramientos — 30/12/2015

Nombramientos. Apoderado: CASTRO ALONSO JOSE LUIS. Datos registrales. T 28632 , F 159, S 8, H M 189128, I/A 341 (21.12.15).

01/12/2015 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-486391

Revocaciones — 01/12/2015

Revocaciones. Apo.Sol.: LOPEZ LOPEZ FERNANDO. Apoderado: SAEZ DE VICENTE CARMEN. Datos registrales. T 28632 , F 159, S 8, H M 189128, I/A 340 (23.11.15).

19/10/2015 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-418102

Ceses/dimisiones — 19/10/2015

Ceses/Dimisiones. Consejero: LUBELLI LUIGI. Datos registrales. T 28632 , F 156, S 8, H M 189128, I/A 335 ( 8.10.15).

18/06/2015 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-248090

Nombramientos — 18/06/2015

Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 28632 , F 119, S 8, H M 189128, I/A 332 (10.06.15).