Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2026 6 tarjetas
20/04/2026 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-190238

Ceses/dimisiones — 20/04/2026

Ceses/Dimisiones. Consejero: SARRION ALCANTUD JULIAN. Presidente: SARRION MARTINEZ JULIAN ENRIQUE. SecreNoConsj: GONZALEZ DELICADO ALFONSO. Nombramientos. SecreNoConsj: CLEMENTE PITA GONZALO. VsecrNoConsj: GONZALEZ DELI...

20/03/2019 Sec. I Cambio de domicilio social Madrid
Madrid-127453

Cambio de domicilio social — 20/03/2019

Cambio de domicilio social. C/ PRINCIPE DE VERGARA 13 - 2º A (MADRID). Datos registrales. T 30481 , F 118, S 8, H M 548538, I/A 6 (13.03.19). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 55 Miércoles 20 de marzo de 2019...

08/11/2018 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-447384

Nombramientos — 08/11/2018

Nombramientos. Apoderado: CABEZUDO COPA JUAN MIGUEL. Datos registrales. T 30481 , F 117, S 8, H M 548538, I/A 5 (31.10.18).

29/01/2018 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-44809

Ceses/dimisiones — 29/01/2018

Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: SANCHEZ GRIÑAN JORGE. Nombramientos. SecreNoConsj: GONZALEZ DELICADO ALFONSO. Consejero: SARRION MARTINEZ JULIAN ENRIQUE. Presidente: SARRION MARTINEZ JULIAN ENRIQUE. Cons.Del.Sol: SARRION...

29/01/2018 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-44810

Nombramientos — 29/01/2018

Nombramientos. Apoderado: CABEZUDO COPA JUAN MIGUEL. Datos registrales. T 30481 , F 115, S 8, H M 548538, I/A 4 (22.01.18).

26/12/2012 Sec. I Constitución Madrid
Madrid-537208

Constitución — 26/12/2012

Constitución. Comienzo de operaciones: 16.11.12. Objeto social: CONTRATACION, GESTION, PROYECCION Y PRESTACION DE SERVICIOS PROPIOS Y EJECUCION DE TODA CLASE DE ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD... Domicilio: C/ FUENTE CISNEROS...