Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2011 6 tarjetas
03/01/2011 Sec. I Disolución Castellón
Castellón-1108

Disolución — 03/01/2011

Disolución. Fusion. Extinción. Datos registrales. T 1494, L 1056, F 223, S 8, H CS 28037, I/A 16 (23.12.10).

05/02/2010 Sec. I Revocaciones Castellón
Castellón-48506

Revocaciones — 05/02/2010

Revocaciones. Apoderado: MARCO MUÑOZ ANTONIO JOSE. Apo.Man.Soli: MARCO MUÑOZ ANTONIO JOSE. Datos registrales. T 1433, L 995, F 225, S 8, H CS 28037, I/A 14 (25.01.10).

21/01/2010 Sec. I Modificaciones estatutarias Castellón
Castellón-22888

Modificaciones estatutarias — 21/01/2010

Modificaciones estatutarias. inclusion articulo 7bis. Datos registrales. T 1433, L 995, F 224, S 8, H CS 28037, I/A 13 (12.01.10).

09/10/2009 Sec. I Revocaciones Castellón
Castellón-425196

Revocaciones — 09/10/2009

Revocaciones. Apo.Man.Soli: ANDREU MOLINER FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 1433, L 995, F 224, S 8, H CS 28037, I/A 11 (29.09.09).

21/08/2009 Sec. I Nombramientos Castellón
Castellón-365253

Nombramientos — 21/08/2009

Nombramientos. Apoderado: PEREZ RODRIGUEZ RAFAEL ANGEL. Datos registrales. T 1433, L 995, F 224, S 8, H CS 28037, I/A 10 (12.08.09).

10/03/2009 Sec. I Revocaciones Castellón
Castellón-122277

Revocaciones — 10/03/2009

Revocaciones. Apo.Man.Soli: AREOSA SASTRE MANUEL. Datos registrales. T 1433, L 995, F 223, S 8, H CS 28037, I/A 9 (27.02.09).