Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2019 21 tarjetas
18/01/2019 Sec. I Cambio de denominación social Madrid
Madrid-21888

Cambio de denominación social — 18/01/2019

Cambio de denominación social. INTRUM SERVICING SPAIN SOCIEDAD ANONIMA. Datos registrales. T 35351 , F 176, S 8, H M 473332, I/A 70 (11.01.19). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 12 Viernes 18 de enero de 2019...

16/10/2018 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-413409

Nombramientos — 16/10/2018

Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 35351 , F 175, S 8, H M 473332, I/A 69 ( 8.10.18).

10/08/2018 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-334168

Ceses/dimisiones — 10/08/2018

Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: SANZ EXPOSITO LUIS-ALBERTO. Datos registrales. T 35351 , F 174, S 8, H M 473332, I/A 67 ( 3.08.18).

10/08/2018 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-334169

Nombramientos — 10/08/2018

Nombramientos. Apo.Manc.: ZURBANO LOPEZ ALEJANDRO;FERNANDEZ ESPEJEL FRANCISCO JAVIER;ARANGUREN DELGADO JAVIER;RUIZ CABRERA CARLOS;RASCON SAN MIGUEL PAULINA. Apo.Sol.: ZURBANO LOPEZ ALEJANDRO. Datos registrales. T 35351...

30/05/2018 Sec. I Cambio de objeto social Madrid
Madrid-227972

Cambio de objeto social — 30/05/2018

Cambio de objeto social. 1a) la adquisición, tenencia, gestión, administración, disposición y enajenación de carteras de deudas de cualquier tipo adquiridas por la Sociedad a entidades financieras o de cualquier otro ti...

30/05/2018 Sec. I Cambio de domicilio social Madrid
Madrid-227973

Cambio de domicilio social — 30/05/2018

Cambio de domicilio social. C/ VIA DE LOS POBLADOS 3 - EDIFICIO 1, PARQUE EMPR (MADRID). Datos registrales. T 35351 , F 174, S 8, H M 473332, I/A 66 (21.05.18).

09/03/2018 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-112761

Revocaciones — 09/03/2018

Revocaciones. Apo.Manc.: ARANGUREN DELGADO FRANCISCO JAVIER. Apoderado: ZURBANO LOPEZ ALEJANDRO. Datos registrales. T 35351 , F 172, S 8, H M 473332, I/A 62 ( 1.03.18).

08/03/2018 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-110144

Nombramientos — 08/03/2018

Nombramientos. Apoderado: ZURBANO LOPEZ ALEJANDRO. Fe de erratas: Se omitió por error en la Inscripción 36ª el nombramiento como apoderado de ZURBANO LOPEZ ALEJANDRO. Datos registrales. T 29492 , F 220, S 8, H M 473332,...

04/12/2017 Sec. I Reelecciones Madrid
Madrid-476255

Reelecciones — 04/12/2017

Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 35351 , F 172, S 8, H M 473332, I/A 60 (27.11.17).

27/10/2017 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-425650

Ceses/dimisiones — 27/10/2017

Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: ZURBANO LOPEZ ALEJANDRO. Consejero: SKALEVIK GEIR INGE. Vicepresid.: SKALEVIK GEIR INGE. Consejero: NYSTEEN KLAUS-ANDERS. Presidente: NYSTEEN KLAUS-ANDERS. Consejero: BRANDSRUD TROND. Nom...

02/06/2017 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-230963

Nombramientos — 02/06/2017

Nombramientos. Apo.Sol.: RUIZ CABRERA CARLOS ADOLFO;GARCIA ALBACETE ESTEBAN;DE LOPE BASANTA MIGUEL ANGEL;SANZ EXPOSITO ALBERTO. Datos registrales. T 35351 , F 165, S 8, H M 473332, I/A 53 (25.05.17).

19/04/2017 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-170037

Nombramientos — 19/04/2017

Nombramientos. Apo.Sol.: MARTINEZ ARANDA AMELIA;MARTIN TIRADO LUIS FERNANDO;HERNANDEZ INIESTA CONSUELO. Datos registrales. T 35351 , F 164, S 8, H M 473332, I/A 50 ( 7.04.17).

19/04/2017 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-170038

Nombramientos — 19/04/2017

Nombramientos. Apo.Sol.: RUIZ CABRERA CARLOS ADOLFO;GARCIA ALBACETE ESTEBAN;DE LOPE BASANTA MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 35351 , F 165, S 8, H M 473332, I/A 51 ( 7.04.17).

01/04/2016 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-145226

Nombramientos — 01/04/2016

Nombramientos. Apoderado: CORRAL GUADAÑO MONICA. Datos registrales. T 29492 , F 224, S 8, H M 473332, I/A 45 (22.03.16).

28/12/2015 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-525857

Nombramientos — 28/12/2015

Nombramientos. Apoderado: ZURBANO LOPEZ ALEJANDRO;SANCHEZ FERNANDEZ EVA;ARANGUREN DELGADO JAVIER;PRADO PRADO MANUEL DE VILLENA JULIO. Datos registrales. T 29492 , F 221, S 8, H M 473332, I/A 37 (18.12.15).

28/12/2015 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-525858

Nombramientos — 28/12/2015

Nombramientos. Apoderado: ZURBANO LOPEZ ALEJANDRO;SANCHEZ FERNANDEZ EVA. Datos registrales. T 29492 , F 222, S 8, H M 473332, I/A 38 (18.12.15).

28/12/2015 Sec. I Reelecciones Madrid
Madrid-525859

Reelecciones — 28/12/2015

Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 29492 , F 222, S 8, H M 473332, I/A 39 (18.12.15).

03/07/2015 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-274084

Ceses/dimisiones — 03/07/2015

Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: PEREZ MARTINEZ DAVID. Revocaciones. Apoderado: PEREZ MARTINEZ DAVID;GUTIERREZ ALCUBILLA JUAN MANUEL;GUTIERREZ ALCUBILLA JUAN MANUEL. Nombramientos. SecreNoConsj: PRADO PARDO-MANUEL DE VIL...

03/07/2015 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-274085

Nombramientos — 03/07/2015

Nombramientos. Apo.Sol.: AMANTEGUI LORENZO JAVIER;MARTIN SAINZ JORGE;BARREDO ALVAREZ MIGUEL;ALVAREZ DE MON GONZALEZ MELCHOR. Datos registrales. T 29492 , F 216, S 8, H M 473332, I/A 30 (26.06.15).

03/07/2015 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-274086

Nombramientos — 03/07/2015

Nombramientos. Apoderado: PRADO PARDO-MANUEL DE VILLENA JULIO. Datos registrales. T 29492 , F 217, S 8, H M 473332, I/A 31 (26.06.15).

03/07/2015 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-274087

Nombramientos — 03/07/2015

Nombramientos. Apoderado: ARANGUREN DELGADO JAVIER. Datos registrales. T 29492 , F 217, S 8, H M 473332, I/A 32 (26.06.15).