Actos destacados
Ceses/dimisiones — 26/09/2017
Ceses/Dimisiones. Auditor: AUDITORA GALEGA DE CONTAS SLP. Datos registrales. T 479 , F 145, S 8, H LU 18063, I/A 6 (14.09.17).
Reelecciones — 02/06/2016
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES S.L. Datos registrales. T 479 , F 145, S 8, H LU 18063, I/A 4 (24.05.16).
Nombramientos — 01/06/2016
Nombramientos. Auditor: AUDITORA GALEGA DE CONTAS SLP. Datos registrales. T 479 , F 145, S 8, H LU 18063, I/A 5 (24.05.16). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 103 Miércoles 1 de junio de 2016 Pág. 25103 cve: BO...
Reducción de capital — 24/07/2015
Reducción de capital. Importe reducción: 1.690.012,00 Euros. Resultante Suscrito: 473.588,00 Euros. Datos registrales. T 1033 , F 27, S 8, H S 4788, I/A 54 (16.07.15).
Sociedad unipersonal — 24/07/2015
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: LOGISTICA ALIMENTARIA S.L. Ceses/Dimisiones. Consejero: PASCUAL GOMEZ CUETARA TOMAS FLORENCIO. Secretario: PASCUAL GOMEZ CUETARA FRANCISCO BORJA. Consejero: PAS...
Ceses/dimisiones — 07/08/2014
Ceses/Dimisiones. Secretario: PASCUAL GOMEZ CUETARA SONIA. Vicepresid.: PASCUAL GOMEZ CUETARA FRANCISCO BORJA. Nombramientos. Secretario: PASCUAL GOMEZ CUETARA FRANCISCO BORJA. Datos registrales. T 1033 , F 27, S 8, H S...
Reelecciones — 30/12/2013
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES S.L. Datos registrales. T 1033 , F 27, S 8, H S 4788, I/A 52 (18.12.13).
Cambio de domicilio social — 30/07/2013
Cambio de domicilio social. CTRA SANTANDER-BILBAO KM 9 Km (ASTILLERO (EL)). Datos registrales. T 1033 , F 26, S 8, H S 4788, I/A 51 (22.07.13).
Reelecciones — 01/02/2013
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES S.L. Datos registrales. T 1033 , F 26, S 8, H S 4788, I/A 50 (23.01.13).
Ceses/dimisiones — 06/07/2012
Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: PASCUAL GOMEZ CUETARA TOMAS FLORENCIO. Nombramientos. Apoderado: PASCUAL GOMEZ CUETARA TOMAS FLORENCIO. Datos registrales. T 1033 , F 26, S 8, H S 4788, I/A 49 (25.06.12).
Revocaciones — 12/06/2012
Revocaciones. Apoderado: CASTAÑEDA CAMARERO ANTONIO;CASTILLA COBO ANTONIO. Apo.Man.Soli: COLOMINA PEREZ DEL RIO JAVIER;CASTAÑEDA CAMARERO ANTONIO;BOTIN MARTIN-BARBADILLO CARLOS. Datos registrales. T 1033 , F 26, S 8, H...
Nombramientos — 05/06/2012
Nombramientos. Apo.Man.Soli: COLOMINA PEREZ DEL RIO JAVIER;BOTIN MARTIN-BARBADILLO CARLOS. Apo.Manc.: GARRIDO SAINZ RUBEN;GARCIA ALVARO CARMELO;VICENTE GIL LORENZO. Apo.Man.Soli: GARCIA CANO SALGADO IGNACIO. Apo.Sol.: D...
Reelecciones — 28/02/2012
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES S.L. Datos registrales. T 940 , F 32, S 8, H S 4788, I/A 46 (15.02.12). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 41 Martes 28 de febrero de 2012 Pág. 10555 cve:...
Nombramientos — 27/04/2011
Nombramientos. Con.Delegado: PASCUAL GOMEZ CUETARA TOMAS FLORENCIO. Datos registrales. T 940 , F 32, S 8, H S 4788, I/A 45 (14.04.11).
Ceses/dimisiones — 01/04/2011
Ceses/Dimisiones. Vicepresid.: PASCUAL GOMEZ CUETARA MARIA PILAR. Con.Delegado: PASCUAL GOMEZ CUETARA TOMAS FLORENCIO. Nombramientos. Vicepresid.: PASCUAL GOMEZ CUETARA FRANCISCO BORJA. Reelecciones. Consejero: PASCUAL...
Reelecciones — 27/01/2011
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES S.L. Datos registrales. T 940 , F 32, S 8, H S 4788, I/A 42 (17.01.11).
Sociedad unipersonal — 29/11/2010
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: GRUPO LECHE PASCUAL S.A. Datos registrales. T 940 , F 31, S 8, H S 4788, I/A 41 (17.11.10).
Revocaciones — 10/11/2010
Revocaciones. Apo.Man.Soli: DE LAS HERAS NIÑO RAFAEL. Datos registrales. T 940 , F 31, S 8, H S 4788, I/A 40 (29.10.10).
Reelecciones — 25/01/2010
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES S.L. Datos registrales. T 940 , F 31, S 8, H S 4788, I/A 39 (13.01.10).
Reelecciones — 09/03/2009
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES S.L. Datos registrales. T 940 , F 31, S 8, H S 4788, I/A 38 (25.02.09).