Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2010 5 tarjetas
08/07/2010 Sec. I Disolución Madrid
Madrid-270348

Disolución — 08/07/2010

Disolución. Fusion. Extinción. Datos registrales. T 27094 , F 193, S 8, H M 28218, I/A 48 (25.06.10).

16/12/2009 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-523975

Nombramientos — 16/12/2009

Nombramientos. Auditor: RONDA SANTANA JUAN. Datos registrales. T 27094 , F 191, S 8, H M 28218, I/A 44 ( 3.12.09).

26/11/2009 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-495692

Nombramientos — 26/11/2009

Nombramientos. Apoderado: PARIS VICENTE GONZALO;CARDENAL IRADIER MARIA. Datos registrales. T 27094 , F 191, S 8, H M 28218, I/A 43 (16.11.09).

25/11/2009 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-493304

Ceses/dimisiones — 25/11/2009

Ceses/Dimisiones. Consejero: PEREZ MUINELO ADELA;ARREDONDO CASTELAR ANTONIO. Nombramientos. Consejero: RAMOS GAYTAN EDUARDO. Datos registrales. T 27094 , F 190, S 8, H M 28218, I/A 41 (13.11.09).

25/11/2009 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-493305

Revocaciones — 25/11/2009

Revocaciones. Apoderado: ARREDONDO CASTELLAR ANTONIO;ARREDONDO CASTELLAR ANTONIO;ARREDONDO CASTELLAR ANTONIO. Apo.Manc.: PEREZ MUINELO MARIA ADELA. Apoderado: PEREZ MUINELO MARIA ADELA;PEREZ MUINELO ADELA;PEREZ MUINELO...