Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2015 14 tarjetas
02/11/2015 Sec. I Disolución Toledo
Toledo-441215

Disolución — 02/11/2015

Disolución. Fusion. Extinción. Datos registrales. T 1476 , F 126, S 8, H TO 2517, I/A 40 (23.10.15).

23/09/2015 Sec. I Otros conceptos: Practicada la nota marginal de cierre provisional Art Toledo
Toledo-385543

Otros conceptos: practicada la nota marginal de cierre provisional art — 23/09/2015

Otros conceptos: Practicada la nota marginal de cierre provisional Art. 231 R.R.M., por plazo de 6 meses a contar desde el 14/09/2015; no habiéndose encontrado obstáculos registrales para la fusión a la que se refiere l...

16/06/2014 Sec. I Revocaciones Toledo
Toledo-251207

Revocaciones — 16/06/2014

Revocaciones. Apo.Manc.: VAZQUEZ MARTIN PABLO. Datos registrales. T 1476 , F 126, S 8, H TO 2517, I/A 39 ( 9.06.14).

27/03/2014 Sec. I Ceses/Dimisiones Toledo
Toledo-138620

Ceses/dimisiones — 27/03/2014

Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: VALDES BUENO FERNANDO;SHARPE II ROBERT ALAIR. Nombramientos. Adm. Unico: VALDES BUENO FERNANDO. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios...

27/03/2014 Sec. I Revocaciones Toledo
Toledo-138621

Revocaciones — 27/03/2014

Revocaciones. Apo.Manc.: SANFELIZ MEZQUITA ALFREDO. Datos registrales. T 1476 , F 126, S 8, H TO 2517, I/A 38 (20.03.14).

18/05/2012 Sec. I Nombramientos Toledo
Toledo-211874

Nombramientos — 18/05/2012

Nombramientos. Apo.Sol.: LOPEZ MARCOS LUIS;GIL RUBIO ISAAC DAVID. Datos registrales. T 1476 , F 119, S 8, H TO 2517, I/A 36 (26.04.12).

02/12/2010 Sec. I Revocaciones Toledo
Toledo-447397

Revocaciones — 02/12/2010

Revocaciones. Apo.Manc.: SANFELIZ MEZQUITA ALFREDO;BELY EMMANUELLE MARIANNE;MONTESINOS BALLESTEROS LUIS;ROSTIROLLA GEROW MARTINE. Nombramientos. Apo.Manc.: SANFELIZ MEZQUITA ALFREDO;BELY EMMANUELLE MARIANNE;MONTESINOS B...

03/11/2010 Sec. I Reelecciones Toledo
Toledo-406395

Reelecciones — 03/11/2010

Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 1476 , F 118, S 8, H TO 2517, I/A 34 (21.10.10).

18/12/2009 Sec. I Reelecciones Toledo
Toledo-527254

Reelecciones — 18/12/2009

Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 1476 , F 118, S 8, H TO 2517, I/A 32 ( 9.12.09).

07/08/2009 Sec. I Revocaciones Toledo
Toledo-349124

Revocaciones — 07/08/2009

Revocaciones. Apoderado: DIAZ FERNANDEZ CASTO;DIAZ DEL RIO TOMAS;PEREZ BAHON RICARDO;PINO MARTINEZ JOSE MANUEL;LOPEZ GARCIA AJOFRIN JOSE MIGUEL;MARCHANTE LOGROÑO MIGUEL VICENTE;PINO MARTINEZ JOSE MANUEL;LOPEZ GARCIA AJO...

07/08/2009 Sec. I Nombramientos Toledo
Toledo-349125

Nombramientos — 07/08/2009

Nombramientos. Apo.Manc.: DUEÑAS GIL FRANCISCO JAVIER;QUILEZ NAVARRO ANTONIO;MONTESINOS BALLESTEROS LUIS;ARAGON DENCHE JAVIER;VAZQUEZ MARTIN PABLO;RODRIGUEZ REVILLA FRANCISCO JAVIER;PRADANOS ALEJOS JOSE ANTONIO. Datos r...

07/08/2009 Sec. I Nombramientos Toledo
Toledo-349126

Nombramientos — 07/08/2009

Nombramientos. Apo.Manc.: SANFELIZ MEZQUITA ALFREDO;BELY EMMANUELLE MARIANNE;MONTESINOS BALLESTEROS LUIS;ROSTIROLLA GEROW MARTINE. Datos registrales. T 1247 , F 164, S 8, H TO 2517, I/A 31 (27.07.09). http://www.boe.es...

24/07/2009 Sec. I Ceses/Dimisiones Toledo
Toledo-329364

Ceses/dimisiones — 24/07/2009

Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: DE LA VIUDA MARTINEZ JESUS. Nombramientos. Adm. Solid.: SHARPE II ROBERT ALAIR. Otros conceptos: Cambiada la denominación del socio único por la de "CAMPOFRIO FOOD GROUP, SA" anteriormente...

25/02/2009 Sec. I Revocaciones Toledo
Toledo-100572

Revocaciones — 25/02/2009

Revocaciones. Apoderado: RIO MARTIN ISIDRO;DEL RIO MARTIN ISIDRO;RUBIALES REGORDAN MANUEL;RAMIRO MORENO GERARDO. Datos registrales. T 1247 , F 163, S 8, H TO 2517, I/A 28 (12.02.09).